INITIATIVE SOFTWARE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINITIATIVE SOFTWARE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC127774
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INITIATIVE SOFTWARE LIMITED ?

    • Développement de logiciels professionnels et grand public (62012) / Information et communication

    Où se situe INITIATIVE SOFTWARE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INITIATIVE SOFTWARE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COMLAW NO. 238 LIMITED05 oct. 199005 oct. 1990

    Quels sont les derniers comptes de INITIATIVE SOFTWARE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour INITIATIVE SOFTWARE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour INITIATIVE SOFTWARE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital au 08 août 2014

    • Capital: GBP 0.10
    4 pagesSH19

    Comptes établis au 30 juin 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes établis au 30 juin 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes établis au 30 juin 2011

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de James Donald Gilmour Wilson en tant que directeur le 21 mars 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Douglas Mcloughlan en tant que directeur le 30 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Kevin Clark en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 9 Charlotte Square Edinburgh Midlothian EH2 4DR le 23 déc. 2010

    2 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2009

    6 pagesAA

    legacy

    6 pagesMG01s

    Nomination de Michael Scott Mcgill en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Douglas Mcloughlan le 08 janv. 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire David William Murray Horne le 12 nov. 2009

    3 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur James Donald Gilmour Wilson le 16 nov. 2009

    3 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de INITIATIVE SOFTWARE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HORNE, David William Murray
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Secrétaire
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    British131680300001
    MCGILL, Michael Scott
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    ScotlandBritish99070570001
    BRUCE, Graeme Murray
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Secrétaire désigné
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002440001
    CALDWELL, John Stewart
    22 Jedburgh Drive
    PA2 9JJ Paisley
    Renfrewshire
    Secrétaire
    22 Jedburgh Drive
    PA2 9JJ Paisley
    Renfrewshire
    British1320640001
    MARSHALL, David
    5 Kelvin Crescent
    Bearsden
    G61 1BT Glasgow
    Secrétaire
    5 Kelvin Crescent
    Bearsden
    G61 1BT Glasgow
    British79453940001
    MCLOUGHLAN, Douglas
    3 Carrongrange Gardens
    FK5 3DU Larbert
    Secrétaire
    3 Carrongrange Gardens
    FK5 3DU Larbert
    British48981460002
    BEATTIE, Kenneth George
    35 Camphill Avenue
    G41 3AX Langside
    Glasgow
    Administrateur
    35 Camphill Avenue
    G41 3AX Langside
    Glasgow
    United KingdomBritish108957650001
    BRUCE, Graeme Murray
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Administrateur désigné
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002440001
    CALDWELL, John Stewart
    22 Jedburgh Drive
    PA2 9JJ Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    22 Jedburgh Drive
    PA2 9JJ Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandBritish1320640001
    CLARK, Kevin Peter
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    United KingdomBritish70888620001
    GALBRAITH, Eric Roger
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Administrateur désigné
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002450001
    MARSHALL, David
    5 Kelvin Crescent
    Bearsden
    G61 1BT Glasgow
    Administrateur
    5 Kelvin Crescent
    Bearsden
    G61 1BT Glasgow
    United KingdomBritish79453940001
    MCLOUGHLAN, Douglas
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    ScotlandBritish165092070001
    NEESON, Paul Gerard
    Duncrag
    Bonhill Road
    G82 2DY Dumbarton
    Administrateur
    Duncrag
    Bonhill Road
    G82 2DY Dumbarton
    ScotlandBritish54148210001
    POWLEY, Moira
    52 Thames Street
    TW16 6AF Lower Sunbury
    Middlesex
    Administrateur
    52 Thames Street
    TW16 6AF Lower Sunbury
    Middlesex
    British53719440001
    SMITH, Alistair George
    2 Ormiston Place
    Lawthorn
    Irvine
    Administrateur
    2 Ormiston Place
    Lawthorn
    Irvine
    British1320660002
    THORBURN, Andrew Scott
    20 Lennox Street Lane
    EH4 1PZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    20 Lennox Street Lane
    EH4 1PZ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish840430001
    WAGA, John
    2 Maple Grove
    Fixby
    HD2 2FG Huddersfield
    Administrateur
    2 Maple Grove
    Fixby
    HD2 2FG Huddersfield
    British54999500001
    WALLACE, David Gordon
    Lethington Road
    G46 6TB Giffnock
    14
    East Renfrewshire
    Administrateur
    Lethington Road
    G46 6TB Giffnock
    14
    East Renfrewshire
    ScotlandBritish140806790001
    WILSON, James Donald Gilmour
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    ScotlandBritish69298770001
    WYATT, Edward Jeremy
    Kirkland Coach House
    Bridgend
    KA24 4DA Dalry
    Ayrshire
    Administrateur
    Kirkland Coach House
    Bridgend
    KA24 4DA Dalry
    Ayrshire
    British1254100001

    INITIATIVE SOFTWARE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 20 avr. 2010
    Livré le 04 mai 2010
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Floating charge
    Créé le 04 déc. 2008
    Livré le 17 déc. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 déc. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 07 déc. 2001
    Livré le 11 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Strathclyde Investment Fund
    Transactions
    • 11 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 06 déc. 2001
    Livré le 21 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Sir Tom Farmer
    Transactions
    • 21 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 06 déc. 2001
    Livré le 20 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aberdeen City Council Superannuation Fund
    Transactions
    • 20 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 06 déc. 2001
    Livré le 20 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glasgow Development Fund
    Transactions
    • 20 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 24 août 2000
    Livré le 31 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish Enterprise
    Transactions
    • 31 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 20 août 1999
    Livré le 26 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish Equity Partnership
    Transactions
    • 26 août 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 sept. 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 mai 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 04 juin 1996
    Livré le 07 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 juin 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 mai 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0