STRATHCLYDE BUSINESS PARK (DEVELOPMENTS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | STRATHCLYDE BUSINESS PARK (DEVELOPMENTS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC128301 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STRATHCLYDE BUSINESS PARK (DEVELOPMENTS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Johnston Carmichael 227 West George Street G2 2ND Glasgow |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STRATHCLYDE BUSINESS PARK (DEVELOPMENTS) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour STRATHCLYDE BUSINESS PARK (DEVELOPMENTS) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 05 nov. 2023 |
Quels sont les derniers dépôts pour STRATHCLYDE BUSINESS PARK (DEVELOPMENTS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 12 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 177 Bothwell Street Glasgow G2 7ER Scotland à C/O Johnston Carmichael 227 West George Street Glasgow G2 2nd le 03 juil. 2024 | 3 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2023 | 8 pages | AA | ||||||||||
legacy | 29 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 juin 2022 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 29 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 4 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Phoenix House Phoenix Crescent Bellshill Lanarkshire ML4 3NJ à 177 Bothwell Street Glasgow G2 7ER le 08 févr. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David John Shearer en tant que directeur le 31 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 23 juin 2021 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 23 déc. 2020 au 23 juin 2021 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr William Dale Hill le 03 nov. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Rosemary Hill le 03 nov. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 23 déc. 2019 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 nov. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 23 déc. 2018 | 7 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de STRATHCLYDE BUSINESS PARK (DEVELOPMENTS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILL, Rosemary | Administrateur | 227 West George Street G2 2ND Glasgow C/O Johnston Carmichael | United Kingdom | British | 50013000004 | |||||
| HILL, William Dale | Administrateur | 227 West George Street G2 2ND Glasgow C/O Johnston Carmichael | United Kingdom | British | 59706640004 | |||||
| DAVIDSON, Karen | Secrétaire | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh Midlothian | British | 1032720001 | ||||||
| HILL, Jean Simpson | Secrétaire | Woodypoint Bonkle ML2 9QF Newmains Lanarkshire | British | 397650001 | ||||||
| MORRISON, John | Secrétaire | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | 1500260013 | ||||||
| RUSSELL, Peter | Secrétaire | 52 Moorfield Edgeworth BL7 0DH Bolton Manchester | British | 10920180001 | ||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Secrétaire | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||
| SHIELDS, Charles Anthony | Secrétaire | Ecus 10 Laurelhill Place FK8 2JH Stirling | British | 75743930001 | ||||||
| CARMICHAEL, Iain James Keith | Administrateur | Holmwood Gardens G71 7BH Uddingston 21 | Scotland | British | 138808270001 | |||||
| COCKBURN, Andrew Scott | Administrateur | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | British | 36549700003 | ||||||
| COOMBS, David Campbell | Administrateur | 160 Mayfield Road EH9 3AP Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 57262900002 | |||||
| DEVINE, Paul John | Administrateur | Little Garth 33 Marmion Road EH39 4PF North Berwick East Lothian | British | 43368870002 | ||||||
| DONNELLY, Anthony | Administrateur | 1 Old Kirk Road Corstorphine EH12 6JY Edinburgh | United Kingdom | British | 109258700001 | |||||
| DONNELLY, Anthony | Administrateur | 1 Old Kirk Road Corstorphine EH12 6JY Edinburgh | United Kingdom | British | 109258700001 | |||||
| ELLISON, Linda | Administrateur | 17 New Edinburgh Road Uddingston G71 6BT Glasgow | Scotland | British | 37282170001 | |||||
| HILL, Robert Thomson | Administrateur | Woodiepoint Bonkle ML2 9QF Newmains | United Kingdom | British | 44406440003 | |||||
| HILL, Stewart Wells | Administrateur | Woodypoint Bonkle ML2 9QF Newmains Wishaw | British | 398220001 | ||||||
| KELLY, Stephen Gerard | Administrateur | 13 Gilmourton Crescent G77 5AE Newton Mearns Lanarkshire | Scotland | British | 142445950001 | |||||
| LAWSON, Andrew Gordon | Administrateur | One The Paddock Seton Mains EH32 0PG Longniddry East Lothian | British | 45002240001 | ||||||
| LAWSON, Andrew Gordon | Administrateur | One The Paddock Seton Mains EH32 0PG Longniddry East Lothian | British | 45002240001 | ||||||
| MACKAY, Alasdair | Administrateur | 88 Cammo Grove EH4 8HD Edinburgh | United Kingdom | British | 1087250001 | |||||
| MACLENNAN, Norman Angus | Administrateur | Croft Na Coille 25 Toberargan Road PH16 5HG Pitlochry Perthshire | British | 75374210001 | ||||||
| MCGILP, Niall Alexander | Administrateur | 87 Low Waters Road ML3 7LG Hamilton Lanarkshire | British | 35766390001 | ||||||
| MCMANUS, John | Administrateur | 75 Mote Hill ML3 6EA Hamilton Lanarkshire | Scotland | British | 43925480001 | |||||
| MCMANUS, John | Administrateur | 75 Mote Hill ML3 6EA Hamilton Lanarkshire | Scotland | British | 43925480001 | |||||
| MURRAY, James Wilson | Administrateur | 39 Elvan Street ML1 3EN Motherwell Lanarkshire | British | 632820001 | ||||||
| RUE, Martyn Daniel | Administrateur | 1 Royal Gardens FK8 2RJ Stirling | British | 48387310001 | ||||||
| SHEARER, David John | Administrateur | Phoenix House Phoenix Crescent ML4 3NJ Bellshill Lanarkshire | United Kingdom | British | 141994460001 | |||||
| SHIELDS, Charles Anthony | Administrateur | Ecus 10 Laurelhill Place FK8 2JH Stirling | Scotland | British | 75743930001 | |||||
| WINWARD, Martin Johnson | Administrateur | Entwhistle House Entwhistle BL7 0LR Bolton Lancashire | England | British | 17166820001 | |||||
| WOODBURN, Pamela | Administrateur | 102 Polwarth Terrace EH11 1NN Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 67596450001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STRATHCLYDE BUSINESS PARK (DEVELOPMENTS) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hfd Construction Group Ltd | 03 sept. 2019 | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Phoenix House Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr William Dale Hill | 30 juin 2016 | Phoenix House Phoenix Crescent ML4 3NJ Bellshill Lanarkshire | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
STRATHCLYDE BUSINESS PARK (DEVELOPMENTS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0