CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC128650 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 24 Blythswood Square G2 4BG Glasgow |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans CVL | 15 pages | LIQ14(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive, Leith, Edinburgh EH6 6JH Scotland à 24 Blythswood Square Glasgow G2 4BG le 21 mars 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP Scotland à C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive Leith Edinburgh EH6 6JH | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018 | 4 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Millar Bryce Bonnington Bond 2 Anderson Place Leith Edinburgh EH6 5NP à C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive, Leith, Edinburgh EH6 6JH le 24 oct. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 3 pages | AA | ||||||||||
Cessation de Michael John Dyson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP Scotland à Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Dyson le 13 août 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 95 Westburn Drive Cambuslang Glasgow G72 7NA Scotland à Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Dyson le 13 août 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andy Dobing en tant que directeur le 24 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael John Dyson en tant qu'administrateur le 13 août 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alastair Richard Gamage en tant que directeur le 16 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Andy Dobing en tant qu'administrateur le 11 juin 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Mel Butler en tant que directeur le 29 janv. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYSON, Michael John | Administrateur | Thorncliffe Park Estate, Newton Chambers Road Chapeltown S35 2PH Sheffield 5 Park Square England | England | British | 73151180001 | |||||
| MONRO, Richard Charles | Secrétaire | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | British | 59480370001 | ||||||
| REID, Brian | Secrétaire désigné | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||
| SMITH, Linda Helen | Secrétaire | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | British | 313940002 | ||||||
| SMITH, Ronnie Mckenzie | Secrétaire | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | British | 313950002 | ||||||
| BUTLER, Mel | Administrateur | Century Way Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 3310 United Kingdom | United Kingdom | British | 187274630001 | |||||
| DOBING, Andrew Paul | Administrateur | Bonnington Bond 2 Anderson Place EH6 5NP Leith C/O Millar Bryce Edinburgh | England | British | 202646660001 | |||||
| DONALD, Neil | Administrateur | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 195321250001 | |||||
| EATOCK, Matthew Joseph | Administrateur | Langsett Road S6 2LW Sheffield Hillsborough Works South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 187184300001 | |||||
| EBSWORTH, Ronald Edwin | Administrateur | 6 Adair Place FK13 6RS Tillicoultry Clackmannanshire | British | 75543300002 | ||||||
| FLEMING, Adam | Administrateur | 5 Langhill Drive Balloch G68 9AP Cumbernauld Lanarkshire | British | 109188480001 | ||||||
| FOTHERINGHAM, Colin George Ewing | Administrateur | Pond View Drain Lane Holme On Spalding Moor YO43 4DQ York East Yorkshire | United Kingdom | British | 82642480001 | |||||
| GAMAGE, Alastair Richard | Administrateur | Century Way Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 3310 United Kingdom | United Kingdom | British | 124982420001 | |||||
| GREENAWAY, Andrew Paul | Administrateur | Langsett Road S6 2LW Sheffield Hillsborough Works South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 120869420001 | |||||
| HUDSON, Jonathan Adrian | Administrateur | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 27743810004 | |||||
| MONRO, Richard Charles | Administrateur | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 59480370001 | |||||
| MONRO, Richard Charles | Administrateur | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 59480370001 | |||||
| SMITH, Linda Helen | Administrateur | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | Scotland | British | 313940002 | |||||
| SMITH, Ronnie Mckenzie | Administrateur | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | Scotland | British | 313950002 | |||||
| WAGHORN, Iain Lawrence | Administrateur | 98 Forfar Road DD4 7BG Dundee | Scotland | British | 40141580001 | |||||
| WAUGH, Joanne | Administrateur désigné | 27 Castle Street EH2 3DN Edinburgh | British | 900000070001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Michael John Dyson | 06 avr. 2016 | Thorncliffe Park, Chapeltown S35 2PH Sheffield Unit 5 Park Square England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Miller Pattison Ltd | 06 avr. 2016 | Thorncliffe Park, Chapeltown S35 2PH Sheffield Unit 5 Park Square England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Créé le 21 avr. 1998 Livré le 27 avr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 21 déc. 1992 Livré le 05 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0