CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED

CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC128650
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?

    • Autres installations en construction (43290) / Construction

    Où se situe CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    24 Blythswood Square
    G2 4BG Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WETPARK LIMITED22 nov. 199022 nov. 1990

    Quels sont les derniers comptes de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans CVL

    15 pagesLIQ14(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive, Leith, Edinburgh EH6 6JH Scotland à 24 Blythswood Square Glasgow G2 4BG le 21 mars 2019

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 18 mars 2019

    LRESEX

    Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP Scotland à C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive Leith Edinburgh EH6 6JH

    1 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Millar Bryce Bonnington Bond 2 Anderson Place Leith Edinburgh EH6 5NP à C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive, Leith, Edinburgh EH6 6JH le 24 oct. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    3 pagesAA

    Cessation de Michael John Dyson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2017

    1 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 avr. 2016

    État du capital au 06 avr. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP Scotland à Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Dyson le 13 août 2015

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 95 Westburn Drive Cambuslang Glasgow G72 7NA Scotland à Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Dyson le 13 août 2015

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andy Dobing en tant que directeur le 24 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael John Dyson en tant qu'administrateur le 13 août 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alastair Richard Gamage en tant que directeur le 16 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Andy Dobing en tant qu'administrateur le 11 juin 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 févr. 2015

    État du capital au 09 févr. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Mel Butler en tant que directeur le 29 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DYSON, Michael John
    Thorncliffe Park Estate, Newton Chambers Road
    Chapeltown
    S35 2PH Sheffield
    5 Park Square
    England
    Administrateur
    Thorncliffe Park Estate, Newton Chambers Road
    Chapeltown
    S35 2PH Sheffield
    5 Park Square
    England
    EnglandBritish73151180001
    MONRO, Richard Charles
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Secrétaire
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    British59480370001
    REID, Brian
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    British900007130001
    SMITH, Linda Helen
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    Secrétaire
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    British313940002
    SMITH, Ronnie Mckenzie
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    Secrétaire
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    British313950002
    BUTLER, Mel
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3310
    United Kingdom
    Administrateur
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3310
    United Kingdom
    United KingdomBritish187274630001
    DOBING, Andrew Paul
    Bonnington Bond
    2 Anderson Place
    EH6 5NP Leith
    C/O Millar Bryce
    Edinburgh
    Administrateur
    Bonnington Bond
    2 Anderson Place
    EH6 5NP Leith
    C/O Millar Bryce
    Edinburgh
    EnglandBritish202646660001
    DONALD, Neil
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritish195321250001
    EATOCK, Matthew Joseph
    Langsett Road
    S6 2LW Sheffield
    Hillsborough Works
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Langsett Road
    S6 2LW Sheffield
    Hillsborough Works
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish187184300001
    EBSWORTH, Ronald Edwin
    6 Adair Place
    FK13 6RS Tillicoultry
    Clackmannanshire
    Administrateur
    6 Adair Place
    FK13 6RS Tillicoultry
    Clackmannanshire
    British75543300002
    FLEMING, Adam
    5 Langhill Drive
    Balloch
    G68 9AP Cumbernauld
    Lanarkshire
    Administrateur
    5 Langhill Drive
    Balloch
    G68 9AP Cumbernauld
    Lanarkshire
    British109188480001
    FOTHERINGHAM, Colin George Ewing
    Pond View Drain Lane
    Holme On Spalding Moor
    YO43 4DQ York
    East Yorkshire
    Administrateur
    Pond View Drain Lane
    Holme On Spalding Moor
    YO43 4DQ York
    East Yorkshire
    United KingdomBritish82642480001
    GAMAGE, Alastair Richard
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3310
    United Kingdom
    Administrateur
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3310
    United Kingdom
    United KingdomBritish124982420001
    GREENAWAY, Andrew Paul
    Langsett Road
    S6 2LW Sheffield
    Hillsborough Works
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Langsett Road
    S6 2LW Sheffield
    Hillsborough Works
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish120869420001
    HUDSON, Jonathan Adrian
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritish27743810004
    MONRO, Richard Charles
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritish59480370001
    MONRO, Richard Charles
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritish59480370001
    SMITH, Linda Helen
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    Administrateur
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    ScotlandBritish313940002
    SMITH, Ronnie Mckenzie
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    Administrateur
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    ScotlandBritish313950002
    WAGHORN, Iain Lawrence
    98 Forfar Road
    DD4 7BG Dundee
    Administrateur
    98 Forfar Road
    DD4 7BG Dundee
    ScotlandBritish40141580001
    WAUGH, Joanne
    27 Castle Street
    EH2 3DN Edinburgh
    Administrateur désigné
    27 Castle Street
    EH2 3DN Edinburgh
    British900000070001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Michael John Dyson
    Thorncliffe Park,
    Chapeltown
    S35 2PH Sheffield
    Unit 5 Park Square
    England
    06 avr. 2016
    Thorncliffe Park,
    Chapeltown
    S35 2PH Sheffield
    Unit 5 Park Square
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Miller Pattison Ltd
    Thorncliffe Park,
    Chapeltown
    S35 2PH Sheffield
    Unit 5 Park Square
    England
    06 avr. 2016
    Thorncliffe Park,
    Chapeltown
    S35 2PH Sheffield
    Unit 5 Park Square
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Numéro d'enregistrement01072847
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 21 avr. 1998
    Livré le 27 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 avr. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 21 déc. 1992
    Livré le 05 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 janv. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 mars 2019Commencement of winding up
    19 août 2020Due to be dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0