COMPITA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMPITA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC128693
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMPITA LIMITED ?

    • Activités de conseil en gestion autres que la gestion financière (70229) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe COMPITA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Coorie Doon Clune Road
    Gowkhall
    KY12 9NZ Dunfermline
    Fife
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de COMPITA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour COMPITA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Retrait de la demande de radiation de la société

    1 pagesDS02

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Derek Gareth Glen en tant qu'administrateur le 01 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gd Corporate Services Limited en tant que directeur le 27 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Derek Gareth Glen en tant que directeur le 30 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Derek Glen en tant que secrétaire le 30 oct. 2014

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de * Software Innovation Centre 1 Michaelson Square Kirkton Campus, Livingston West Lothian, EH54 7DP* le 30 janv. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 janv. 2014

    État du capital au 15 janv. 2014

    • Capital: GBP 126,999.959
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    7 pagesAA

    Inscription de la charge 1286930003

    11 pagesMR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Gd Corporate Services Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Nomination de Mr Derek Glen en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Cyril Dyer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Clark en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Clark en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Derek Glen en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Marshall Craigmyle en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de COMPITA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GLEN, Derek Gareth
    Clune Road
    Gowkhall
    KY12 9NZ Dunfermline
    Coorie Doon
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    Clune Road
    Gowkhall
    KY12 9NZ Dunfermline
    Coorie Doon
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritishDirector130935870001
    CLARK, Robert
    71b Townhill Road
    KY12 0BN Dunfermline
    Fife
    Secrétaire
    71b Townhill Road
    KY12 0BN Dunfermline
    Fife
    BritishCompany Director38384400002
    CRAIGMYLE, Elizabeth White
    1 Somerset Avenue
    ML3 9BS Hamilton
    Lanarkshire
    Secrétaire
    1 Somerset Avenue
    ML3 9BS Hamilton
    Lanarkshire
    British1293480001
    CRAIGMYLE, Marshall
    27 Hills Road
    ML10 6LQ Strathaven
    Lanarkshire
    Secrétaire
    27 Hills Road
    ML10 6LQ Strathaven
    Lanarkshire
    United KingdomCompany Director72197460001
    CRAIGMYLE, Marshall
    27 Hills Road
    ML10 6LQ Strathaven
    Lanarkshire
    Secrétaire
    27 Hills Road
    ML10 6LQ Strathaven
    Lanarkshire
    United Kingdom72197460001
    ELLIOTT, Alwin Victor
    Cruachan
    Seton Dean
    EH32 0PW Longniddry
    E Lothian
    Secrétaire
    Cruachan
    Seton Dean
    EH32 0PW Longniddry
    E Lothian
    British162890001
    GLEN, Derek
    Clune Road
    Gowkhall
    KY12 9NZ Dunfermline
    Coorie Doon
    Fife
    Scotland
    Secrétaire
    Clune Road
    Gowkhall
    KY12 9NZ Dunfermline
    Coorie Doon
    Fife
    Scotland
    167118480001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    ANGUS, Edward
    Woodfield 20 High Street
    EH18 1ND Lasswade
    Midlothian
    Administrateur
    Woodfield 20 High Street
    EH18 1ND Lasswade
    Midlothian
    ScotlandBritishBusiness Director349660001
    ANGUS, Edward
    Woodfield 20 High Street
    EH18 1ND Lasswade
    Midlothian
    Administrateur
    Woodfield 20 High Street
    EH18 1ND Lasswade
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director349660001
    BEDDIE, Lesley Anne
    83 Balgreen Road
    EH12 5UA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    83 Balgreen Road
    EH12 5UA Edinburgh
    Midlothian
    BritishUniversity Head Of Department27178500001
    CLARK, Robert
    71b Townhill Road
    KY12 0BN Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    71b Townhill Road
    KY12 0BN Dunfermline
    Fife
    ScotlandBritishBusiness Development38384400002
    CRAIGMYLE, Marshall
    27 Hills Road
    ML10 6LQ Strathaven
    Lanarkshire
    Administrateur
    27 Hills Road
    ML10 6LQ Strathaven
    Lanarkshire
    ScotlandUnited KingdomComputer Consultant72197460001
    DYER, Cyril Alexander
    Saltcoats Gardens
    Bellsquarry
    EH54 9JD Livingston
    23
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Saltcoats Gardens
    Bellsquarry
    EH54 9JD Livingston
    23
    West Lothian
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector112480480002
    ELLIOTT, Alwin Victor
    Cruachan
    Seton Dean
    EH32 0PW Longniddry
    E Lothian
    Administrateur
    Cruachan
    Seton Dean
    EH32 0PW Longniddry
    E Lothian
    BritishCompany Director162890001
    FERGUSON, Kathleen
    High Honeyholm
    By Balfrom
    G63 0QE
    Stirlingshire
    Administrateur
    High Honeyholm
    By Balfrom
    G63 0QE
    Stirlingshire
    ScotlandBritishProduct Manager20342100001
    FLETCHER, Ronald Irwin
    17 Glasgow Road
    G71 7AU Uddingston
    Glasgow
    Administrateur
    17 Glasgow Road
    G71 7AU Uddingston
    Glasgow
    BritishManagement Consultant95664900001
    GLEN, Derek Gareth
    Clune Road
    Gowkhall
    KY12 9NZ Dunfermline
    Coorie Doon
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    Clune Road
    Gowkhall
    KY12 9NZ Dunfermline
    Coorie Doon
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritishManaging Director130935870001
    MACPHERSON, Alastair George Murray
    The Creel 26 East Green
    KY10 3AA Anstruther
    Fife
    Administrateur
    The Creel 26 East Green
    KY10 3AA Anstruther
    Fife
    BritishManagement Consultant32860002
    PRINGLE, Lesley
    Stripeside House
    Crombie
    KY12 8LQ Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    Stripeside House
    Crombie
    KY12 8LQ Dunfermline
    Fife
    BritishOperations Manager61275560001
    WORDEN, John Leonard
    Sommerfield Cottage
    Hospital Road
    EH41 3PA Haddington
    East Lothian
    Administrateur
    Sommerfield Cottage
    Hospital Road
    EH41 3PA Haddington
    East Lothian
    United KingdomBritishUniversity Dean90637830001
    GD CORPORATE SERVICES LIMITED
    Quarrywood Court
    EH54 6AX Livingston
    Argyll House
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    Quarrywood Court
    EH54 6AX Livingston
    Argyll House
    West Lothian
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC430594
    173364220001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    COMPITA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 juil. 2013
    Livré le 24 juil. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • East of Scotland Investment Fund Limite
    Transactions
    • 24 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Floating charge
    Créé le 10 juin 2011
    Livré le 22 juin 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • East of Scotland Investment Fund Limited
    Transactions
    • 22 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 22 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 25 mai 1993
    Livré le 04 juin 1993
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 juin 1993Enregistrement d'une charge (410)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0