PUB.COM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPUB.COM LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC129094
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéOui

    Quel est l'objet de PUB.COM LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PUB.COM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    SC129094 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS
    24238
    EH7 9HR Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PUB.COM LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EAGLE TAVERNS LIMITED10 sept. 199110 sept. 1991
    FORECO LIMITED20 déc. 199020 déc. 1990

    Quels sont les derniers comptes de PUB.COM LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au15 août 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PUB.COM LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au21 févr. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour PUB.COM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Adresse du siège social modifiée à PO Box 24238, Sc129094 - Companies House Default Address, Edinburgh, EH7 9HR le 22 juil. 2025

    1 pagesRP05

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    8 pagesLIQ13(Scot)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    pagesGAZ1

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 mars 2023

    LRESSP

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital au 09 mars 2023

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    legacy

    2 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Statuts

    8 pagesMA

    Nomination de Mr Derek Anthony Howell en tant qu'administrateur le 01 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Removal and appointment of company directors 01/02/2023
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Stephen Peter Dando en tant que directeur le 01 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Edward Michael Bashforth en tant que directeur le 01 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Francesca Appleby en tant que secrétaire le 22 août 2022

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 15 août 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 206 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 21 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 16 août 2020

    17 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 24 août 2020 au 11 août 2020

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 18 août 2019

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 févr. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 18 août 2018

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PUB.COM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOWELL, Derek Anthony
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    Administrateur
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    United KingdomBritish299032280001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191628150001
    BURNETT, Andrew Alan
    38 Templeland Road
    EH12 8RP Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire
    38 Templeland Road
    EH12 8RP Edinburgh
    Lothian
    British41431820001
    CROSS, Anthony
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    British1812400001
    DEEGAN, Jayne
    5 Hardstruggle Row
    Eskdaleside
    YO22 5ET Sleights
    North Yorkshire
    Secrétaire
    5 Hardstruggle Row
    Eskdaleside
    YO22 5ET Sleights
    North Yorkshire
    British94870790001
    HAMILTON, William Burt
    Douglas House 58c Allanfauld Road
    Cumbernauld
    Glasgow
    Secrétaire
    Douglas House 58c Allanfauld Road
    Cumbernauld
    Glasgow
    British1054590001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488580001
    MILLER, Nicola Jane
    27 Hillston Close
    TS26 0PE Hartlepool
    Secrétaire
    27 Hillston Close
    TS26 0PE Hartlepool
    British95390370001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    SILLARS, Steven
    36 Nevis Road
    PA4 0PD Renfrew
    Renfrewshire
    Secrétaire
    36 Nevis Road
    PA4 0PD Renfrew
    Renfrewshire
    British53346570001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161694520001
    MACROBERTS CORPORATE SERVICES LIMITED
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Scotland
    Secrétaire
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Scotland
    53781850001
    ARMSTRONG, Michael John
    Hunters Gate 56 Palace Road
    HG4 1HA Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hunters Gate 56 Palace Road
    HG4 1HA Ripon
    North Yorkshire
    British16410290001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BRANNAN, Robert
    13 Carlingnose Way
    North Queensferry
    KY11 1EU Inverkeithing
    Fife
    Administrateur
    13 Carlingnose Way
    North Queensferry
    KY11 1EU Inverkeithing
    Fife
    United KingdomBritish64147580002
    BURNETT, Andrew Alan
    38 Templeland Road
    EH12 8RP Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    38 Templeland Road
    EH12 8RP Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish41431820001
    CHALMERS, Judith Isobel
    Flat 2, 31 Silverwells Crescent
    Bothwell
    G71 8DP Strathclyde
    Administrateur
    Flat 2, 31 Silverwells Crescent
    Bothwell
    G71 8DP Strathclyde
    British71716940002
    CRAIG, Frederick John Robert
    Gateside
    KY14 7SX Cupar
    Freeland
    Fife
    United Kingdom
    Administrateur
    Gateside
    KY14 7SX Cupar
    Freeland
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritish133316040001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GRIER, Ian Birrell
    5 Forrest Drive
    G61 4SJ Bearsden
    Administrateur
    5 Forrest Drive
    G61 4SJ Bearsden
    ScotlandBritish87612170001
    GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish55975990001
    GUNDRY, Richard
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    British107010490001
    HAMILTON, William Burt
    Douglas House 58c Allanfauld Road
    Cumbernauld
    Glasgow
    Administrateur
    Douglas House 58c Allanfauld Road
    Cumbernauld
    Glasgow
    British1054590001
    JENKINS, Stuart Nicol
    Parkview, 7 Arden Drive
    Giffnock
    G46 7AF Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Parkview, 7 Arden Drive
    Giffnock
    G46 7AF Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish116623260001
    LAING, Peter John
    56/1 Timberbush
    Leith
    EH6 6QH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    56/1 Timberbush
    Leith
    EH6 6QH Edinburgh
    Midlothian
    British82725660001
    MACKINNON, David Donaldson
    15 Victoria Road
    PA19 1LD Gourock
    Administrateur
    15 Victoria Road
    PA19 1LD Gourock
    ScotlandBritish116526660001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MCNULTY, John Vincent
    7 Romney Avenue
    G44 5AW Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Romney Avenue
    G44 5AW Glasgow
    Lanarkshire
    British1103140001
    MORRISON, William
    15 Nursery Grove
    PA13 4NH Kilmacolm
    Renfrewshire
    Administrateur
    15 Nursery Grove
    PA13 4NH Kilmacolm
    Renfrewshire
    British53297620001
    O'CALLAGHAN, Francis
    21 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    Administrateur
    21 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    ScotlandBritish557570001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    SANDS, John Robert
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    Administrateur
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    United KingdomBritish141561650001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PUB.COM LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4187608
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PUB.COM LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 mars 2023Commencement of winding up
    27 août 2025Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0