PUB.COM LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PUB.COM LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC129094 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Oui |
Où se situe PUB.COM LIMITED ?
| Adresse du siège social | SC129094 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS 24238 EH7 9HR Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PUB.COM LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 15 août 2021 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PUB.COM LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 févr. 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour PUB.COM LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Adresse du siège social modifiée à PO Box 24238, Sc129094 - Companies House Default Address, Edinburgh, EH7 9HR le 22 juil. 2025 | 1 pages | RP05 | ||||||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 8 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | pages | GAZ1 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital au 09 mars 2023
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statuts | 8 pages | MA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Derek Anthony Howell en tant qu'administrateur le 01 févr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Peter Dando en tant que directeur le 01 févr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Edward Michael Bashforth en tant que directeur le 01 févr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Francesca Appleby en tant que secrétaire le 22 août 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 15 août 2021 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 févr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 206 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 févr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 16 août 2020 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 24 août 2020 au 11 août 2020 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 18 août 2019 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 févr. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 18 août 2018 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de PUB.COM LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWELL, Derek Anthony | Administrateur | Chamberlain Square B3 3AX Birmingham One England | United Kingdom | British | 299032280001 | |||||
| APPLEBY, Francesca | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191628150001 | |||||||
| BURNETT, Andrew Alan | Secrétaire | 38 Templeland Road EH12 8RP Edinburgh Lothian | British | 41431820001 | ||||||
| CROSS, Anthony | Secrétaire | 38 The Lane Spinkhill S21 3YF Sheffield South Yorkshire | British | 1812400001 | ||||||
| DEEGAN, Jayne | Secrétaire | 5 Hardstruggle Row Eskdaleside YO22 5ET Sleights North Yorkshire | British | 94870790001 | ||||||
| HAMILTON, William Burt | Secrétaire | Douglas House 58c Allanfauld Road Cumbernauld Glasgow | British | 1054590001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175488580001 | |||||||
| MILLER, Nicola Jane | Secrétaire | 27 Hillston Close TS26 0PE Hartlepool | British | 95390370001 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secrétaire | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| SILLARS, Steven | Secrétaire | 36 Nevis Road PA4 0PD Renfrew Renfrewshire | British | 53346570001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161694520001 | |||||||
| MACROBERTS CORPORATE SERVICES LIMITED | Secrétaire | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Scotland | 53781850001 | |||||||
| ARMSTRONG, Michael John | Administrateur | Hunters Gate 56 Palace Road HG4 1HA Ripon North Yorkshire | British | 16410290001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BRANNAN, Robert | Administrateur | 13 Carlingnose Way North Queensferry KY11 1EU Inverkeithing Fife | United Kingdom | British | 64147580002 | |||||
| BURNETT, Andrew Alan | Administrateur | 38 Templeland Road EH12 8RP Edinburgh Lothian | Scotland | British | 41431820001 | |||||
| CHALMERS, Judith Isobel | Administrateur | Flat 2, 31 Silverwells Crescent Bothwell G71 8DP Strathclyde | British | 71716940002 | ||||||
| CRAIG, Frederick John Robert | Administrateur | Gateside KY14 7SX Cupar Freeland Fife United Kingdom | Scotland | British | 133316040001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GRIER, Ian Birrell | Administrateur | 5 Forrest Drive G61 4SJ Bearsden | Scotland | British | 87612170001 | |||||
| GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | England | British | 55975990001 | |||||
| GUNDRY, Richard | Administrateur | Holgate Farm 29 The Street Bunwell NR16 1NA Norwich Norfolk | British | 107010490001 | ||||||
| HAMILTON, William Burt | Administrateur | Douglas House 58c Allanfauld Road Cumbernauld Glasgow | British | 1054590001 | ||||||
| JENKINS, Stuart Nicol | Administrateur | Parkview, 7 Arden Drive Giffnock G46 7AF Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 116623260001 | |||||
| LAING, Peter John | Administrateur | 56/1 Timberbush Leith EH6 6QH Edinburgh Midlothian | British | 82725660001 | ||||||
| MACKINNON, David Donaldson | Administrateur | 15 Victoria Road PA19 1LD Gourock | Scotland | British | 116526660001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Administrateur | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MCNULTY, John Vincent | Administrateur | 7 Romney Avenue G44 5AW Glasgow Lanarkshire | British | 1103140001 | ||||||
| MORRISON, William | Administrateur | 15 Nursery Grove PA13 4NH Kilmacolm Renfrewshire | British | 53297620001 | ||||||
| O'CALLAGHAN, Francis | Administrateur | 21 Hamilton Avenue Pollokshields G41 4JG Glasgow | Scotland | British | 557570001 | |||||
| PRESTON, Neil David | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| SANDS, John Robert | Administrateur | 11 Falcon Lane Norton TS20 1LS Stockton On Tees | United Kingdom | British | 141561650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PUB.COM LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punch Taverns (Pmt) Limited | 06 avr. 2016 | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
PUB.COM LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0