J & W HARRIS PROPERTIES LIMITED

J & W HARRIS PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJ & W HARRIS PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC129556
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de J & W HARRIS PROPERTIES LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe J & W HARRIS PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    47 West Main Street
    Blackburn
    EH47 7LT Bathgate
    West Lothian
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de J & W HARRIS PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NELSON OF ARMADALE LIMITED11 mars 199111 mars 1991
    CITYDAILY LIMITED24 janv. 199124 janv. 1991

    Quels sont les derniers comptes de J & W HARRIS PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour J & W HARRIS PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01
    S2KFBSNF

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 avr. 2013

    État du capital au 29 avr. 2013

    • Capital: GBP 10,000
    SH01
    X27B6LDF

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de West End Garage West Main Street Armadale West Lothian EH48 3LT Scotland

    1 pagesAD02
    X27B6LD7

    Changement d'adresse du siège social de West End Garage West Main Street Armadale West Lothian EH48 3LT le 29 avr. 2013

    1 pagesAD01
    X27B6LCZ

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2012

    4 pagesAA
    S236S9C8

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    X1DYL6Z7

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2011

    5 pagesAA
    S13OUPYY

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    XCSNNTAE

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 100 Union Street Aberdeen AB10 1QR Scotland

    1 pagesAD02
    XCSNMTAD

    Cessation de la nomination de Peterkins en tant que secrétaire

    1 pagesTM02
    XCSNLTAC

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2010

    5 pagesAA
    SWAYHS16

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    XYTKZH2Q

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03
    XYTKYH2P

    Modification des coordonnées de l'administrateur William Harris le 29 janv. 2010

    2 pagesCH01
    XYTKWH2N

    Modification des coordonnées de l'administrateur James William Richard Harris le 29 janv. 2010

    2 pagesCH01
    XYTKVH2M

    Modification des coordonnées du secrétaire Messrs Peterkins le 29 janv. 2010

    2 pagesCH04
    XYTKUH2L

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02
    XYTKXH2O

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2009

    6 pagesAA
    SBNELFZ3

    legacy

    1 pages287
    SK8JZ9V6

    legacy

    1 pages225
    SLXFC8MV

    legacy

    3 pages363a
    XLI7C6UJ

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 12 déc. 2007

    5 pagesAA
    SWYSX0W7

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de J & W HARRIS PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARRIS, James William Richard
    15 Old Mill Grove
    Whitburn
    EH47 0LW Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    15 Old Mill Grove
    Whitburn
    EH47 0LW Bathgate
    West Lothian
    ScotlandBritishMotor Dealer114476010001
    HARRIS, William
    40 Kettil'stoun Mains
    EH49 6SL Linlithgow
    Administrateur
    40 Kettil'stoun Mains
    EH49 6SL Linlithgow
    United KingdomBritishMotor Dealer46671730002
    HARCUS, Ronald John
    30 Blackie Road
    EH6 7ND Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    30 Blackie Road
    EH6 7ND Edinburgh
    Midlothian
    BritishOffice Manager1232590001
    NELSON, Elizabeth Carson
    Nelizca
    Entryfoot
    EH48 3AG Blackridge
    West Lothian
    Secrétaire
    Nelizca
    Entryfoot
    EH48 3AG Blackridge
    West Lothian
    British1364410001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    PETERKINS
    Union Street
    AB10 1QR Aberdeen
    100
    Scotland
    Secrétaire
    Union Street
    AB10 1QR Aberdeen
    100
    Scotland
    Forme juridiquePARTNERSHIP
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleSCOTLAND
    40872440001
    NELSON, Elizabeth Carson
    Nelizca
    Entryfoot
    EH48 3AG Blackridge
    West Lothian
    Administrateur
    Nelizca
    Entryfoot
    EH48 3AG Blackridge
    West Lothian
    BritishDirector1364410001
    NELSON, John William
    Nelizca
    Entryfoot
    EH48 3AG Blackridge
    West Lothian
    Administrateur
    Nelizca
    Entryfoot
    EH48 3AG Blackridge
    West Lothian
    BritishDirector1364400001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    J & W HARRIS PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 10 mai 1994
    Livré le 19 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £200,000 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    East end service station, armadale, west lothian.
    Personnes ayant droit
    • Conoco Limited
    Transactions
    • 19 mai 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 09 sept. 1993
    Livré le 10 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nws Trust Limited
    Transactions
    • 10 sept. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 sept. 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 nov. 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 20 mai 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 30 juil. 1992
    Livré le 19 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot of ground in armadale comprising part of subjects forming east end garage armadale.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 août 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 17 juil. 1992
    Livré le 17 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot of ground extending to 25 poles at armadale, west lothian, disposition by james wood limited in favour of peter wardlaw recorded grs linlithgow 30/07/01.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 juil. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 août 1991
    Livré le 02 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Property in armadale west lothian see paper apart.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 août 1991
    Livré le 20 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    East end service station, bathgate road, armadale.
    Personnes ayant droit
    • Conoco LTD
    Transactions
    • 20 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 10 juil. 1991
    Livré le 19 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • N W S Bank PLC
    Transactions
    • 19 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 16 avr. 1991
    Livré le 22 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 30 sept. 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 nov. 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 mai 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 18 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0