DETAILAGENT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DETAILAGENT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC129563 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DETAILAGENT LIMITED ?
| Adresse du siège social | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DETAILAGENT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DETAILAGENT LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 juil. 2025 |
Quels sont les derniers dépôts pour DETAILAGENT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Nomination de Mr Paul Dempsey en tant que secrétaire le 04 juil. 2025 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nizar Bahadurali Pabani en tant que secrétaire le 04 juil. 2025 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2025 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Lynott en tant que directeur le 30 juin 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||||||
Notification de Kwik-Fit Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 mars 2025 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Kwik-Fit Euro Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 mars 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||
État du capital au 26 mars 2025
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 26 mars 2025
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 26 mars 2025
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Kwik Fit Euro Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024 | 18 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023 | 18 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de DETAILAGENT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMPSEY, Paul | Secrétaire | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | 337999950001 | |||||||
| FUKUDA, Takeshi | Administrateur | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | Japanese | 247034300001 | |||||
| BLACK, Lysanne Jane Warren | Secrétaire | 2a Carlton Street EH4 1NJ Edinburgh Midlothian Scotland | British | 46707740001 | ||||||
| BOTHWELL, Karen Margaret | Secrétaire | 25 Belford Gardens EH4 3EP Edinburgh Midlothian | British | 34800860001 | ||||||
| ELLIS, Ian Vincent | Secrétaire | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | British | 162126350001 | ||||||
| HEALY, Michael Joseph Anthony | Secrétaire | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | British | 99111340001 | ||||||
| HUNTER, John Stewart | Secrétaire | 27 Queens Crescent EH9 2BA Edinburgh | British | 1127070001 | ||||||
| MACRAE, Alistair Ian | Secrétaire | 15 Connaught Place EH6 4RQ Edinburgh Midlothian | British | 1361440002 | ||||||
| MCGILL, Kenneth Andrew | Secrétaire | 4 Peastonbank Farm Cottages By Pencaitland EH34 5ET Tranent East Lothian | British | 41923940001 | ||||||
| MORRISON, Scott | Secrétaire | 24 Gaveston Road CV32 6EU Leamington Spa Warwickshire | British | 99297890001 | ||||||
| PABANI, Nizar Bahadurali | Secrétaire | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | 278088870001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secrétaire désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| BARKLEY, John | Administrateur | 10 Willow Tree Place The Beeches EH14 5AZ Balerno Edinburgh, Midlothian | British | 18955940002 | ||||||
| BISSETT, Graeme | Administrateur | 123 Saint Vincent Street G2 5EA Glasgow | British | 79800380001 | ||||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Administrateur | 6 Devonshire Terrace G12 0XF Glasgow | British | 34265760001 | ||||||
| FRASER, Ian Ellis | Administrateur | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | Scotland | Uk | 28393850006 | |||||
| HARADA, Yasuyuki | Administrateur | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | Japanese | 247034000001 | |||||
| HEALY, Michael Joseph Anthony | Administrateur | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | United Kingdom | British | 99111340001 | |||||
| HOUSTON, John Mclellan | Administrateur | The Rock 3 Douglas Avenue PA14 6PE Langbank | British | 712840002 | ||||||
| HUTHERSALL, Robert | Administrateur | 56 Pentland Drive EH10 6PX Edinburgh | British | 3204110005 | ||||||
| LANDAU, Ervin | Administrateur | 78 Harley House Marylebone Road NW1 5HN London | United Kingdom | British | 91134410001 | |||||
| LESLIE, Colin David | Administrateur | 12 Viewbank View EH19 2HU Bonnyrigg Midlothian | British | 1358070001 | ||||||
| LESLIE, Colin David | Administrateur | 12 Viewbank View EH19 2HU Bonnyrigg Midlothian | British | 1358070001 | ||||||
| LYNOTT, Mark | Administrateur | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | British | 186944700003 | |||||
| MACINTYRE, Iain | Administrateur | Holly Lodge 33 Kaimes Road EH12 6JS Corstorphine Edinburgh | British | 35375540002 | ||||||
| MASTERTON, Gavin George | Administrateur | 6 Coldingham Place Garvock Hill KY12 7XS Dunfermline Fife | United Kingdom | British | 663070001 | |||||
| MCGILL, Colin Scott | Administrateur | 10 Wester Coates Avenue EH12 5LS Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 663080001 | |||||
| MCGILL, Kenneth Andrew | Administrateur | 4 Peastonbank Farm Cottages By Pencaitland EH34 5ET Tranent East Lothian | British | 41923940001 | ||||||
| MCGILL, Kenneth Andrew | Administrateur | 4 Peastonbank Farm Cottages By Pencaitland EH34 5ET Tranent East Lothian | British | 41923940001 | ||||||
| MURAI, Kenji | Administrateur | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | Japanese | 95702340002 | |||||
| OGURA, Kazushi | Administrateur | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | Japanese | 150485750001 | |||||
| OWENS, Stanley Hart | Administrateur | 15b Ewerland Barnton EH4 6DH Edinburgh | American | 75755850002 | ||||||
| PARKER, James Robert | Administrateur | 29 Netherton Road TW1 1LZ Twickenham Middlesex | England | British | 112964470001 | |||||
| PARKER, Timothy Charles | Administrateur | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | United Kingdom | British | 126476060001 | |||||
| SLADE, Mark Richard | Administrateur | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | British | 185568260001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DETAILAGENT LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwik-Fit Holdings Limited | 27 mars 2025 | Avenue One SG6 2HU Letchworth Garden City Etel House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Shinjiro Tanaka | 01 mars 2019 | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | Oui | ||||||||||
Nationalité: Japanese Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Yasuyuki Harada | 01 avr. 2018 | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | Oui | ||||||||||
Nationalité: Japanese Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Kwik-Fit Euro Limited | 06 avr. 2016 | Avenue One SG6 2HU Letchworth Garden City Etel House Hertfordshire England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Kenji Murai | 06 avr. 2016 | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | Oui | ||||||||||
Nationalité: Japanese Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0