REIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED

REIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC129717
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe REIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    395 King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LYCIDAS (188) LIMITED31 janv. 199131 janv. 1991

    Quels sont les derniers comptes de REIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour REIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au03 janv. 2024

    Quels sont les derniers dépôts pour REIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    État du capital au 21 févr. 2024

    • Capital: GBP 2
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account from £3,850 to zero 20/02/2024
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 03 janv. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 janv. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Reiver Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 oct. 2022

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Carmuirs House 300 Stirling Road Larbert Stirlingshire FK5 3NJ à 395 King Street Aberdeen AB24 5RP le 05 oct. 2022

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    5 pagesAA

    Nomination de Mr David John Mark Blizzard en tant que secrétaire le 09 août 2022

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jarlath Delphene Wade en tant que secrétaire le 09 août 2022

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Jarlath Delphene Wade en tant que secrétaire le 01 juin 2021

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Brian Alexander en tant que directeur le 21 mai 2021

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Colin Brown en tant qu'administrateur le 01 févr. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Silvana Nerina Glibota-Vigo en tant que secrétaire le 31 juil. 2020

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Silvana Nerina Glibota-Vigo en tant que secrétaire le 15 nov. 2019

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de REIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BLIZZARD, David John Mark
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    Secrétaire
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    299099590001
    BROWN, Colin
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    The Point, 8th Floor
    England
    Administrateur
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    The Point, 8th Floor
    England
    ScotlandBritish85970020004
    JARVIS, Andrew Simon
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    Administrateur
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    United KingdomBritish230200500001
    BARRIE, Sidney
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Secrétaire
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    British149772960001
    GLIBOTA-VIGO, Silvana Nerina
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    Secrétaire
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    264607500001
    HAMPSON, Michael
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    United Kingdom
    Secrétaire
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    United Kingdom
    217953280001
    LEWIS, Paul Michael
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    United Kingdom
    Secrétaire
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    United Kingdom
    162148130001
    MATHIESON, Thomas
    Mizpah 9 Newhouse Drive
    FK1 5PE Falkirk
    Secrétaire
    Mizpah 9 Newhouse Drive
    FK1 5PE Falkirk
    British42422590001
    METHVEN, John Bruce
    Northcote
    Barr Road
    TD1 3HX Galashiels
    Selkirkshire
    Secrétaire
    Northcote
    Barr Road
    TD1 3HX Galashiels
    Selkirkshire
    British46223280001
    SHARKEY, John
    44 Kiltarie Crescent
    ML6 8NL Airdrie
    Lanarkshire
    Secrétaire
    44 Kiltarie Crescent
    ML6 8NL Airdrie
    Lanarkshire
    British63411450002
    STEWART, David Black
    16 Tullylumb Terrace
    PH1 1BA Perth
    Secrétaire
    16 Tullylumb Terrace
    PH1 1BA Perth
    British63981860001
    WADE, Jarlath Delphene
    The Point
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    8th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Point
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    8th Floor
    United Kingdom
    284237170001
    WELCH, Robert John
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    Secrétaire
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    189249100001
    LYCIDAS SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    900003290001
    ALEXANDER, David Brian
    Donisthorpe Street
    LS10 1PL Leeds
    Hunslet Park Depot
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Donisthorpe Street
    LS10 1PL Leeds
    Hunslet Park Depot
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish20404660006
    BARKER, Neil James
    Victoria Road
    G42 7AD Glasgow
    197
    United Kingdom
    Administrateur
    Victoria Road
    G42 7AD Glasgow
    197
    United Kingdom
    EnglandBritish165014000001
    DESMOND, Jane
    6 The Hedgerows
    Lychpit
    RG24 8FQ Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    6 The Hedgerows
    Lychpit
    RG24 8FQ Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish117080470001
    DUNCAN, Robert Alexander
    21 Rubislaw Den South
    AB15 4BD Aberdeen
    Scotland
    Administrateur
    21 Rubislaw Den South
    AB15 4BD Aberdeen
    Scotland
    British48510002
    HUGHES, Patrick
    44 Ironmills Road
    EH22 1JP Dalkeith
    Midlothian
    Administrateur
    44 Ironmills Road
    EH22 1JP Dalkeith
    Midlothian
    British1407920001
    JUFFS, Brian
    14 Belmont Gardens
    Haydon Bridge
    NE47 6HG Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    14 Belmont Gardens
    Haydon Bridge
    NE47 6HG Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish105031650001
    LOCKHEAD, Moir, Sir
    Glassel House
    Glassel
    AB31 4DH Banchory
    Aberdeenshire
    Scotland
    Administrateur
    Glassel House
    Glassel
    AB31 4DH Banchory
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish56009610001
    MAIR, George Alexander
    Newburgh Circle
    Bridge Of Don
    AB22 8QZ Aberdeen
    32
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Newburgh Circle
    Bridge Of Don
    AB22 8QZ Aberdeen
    32
    Aberdeenshire
    British41378180002
    MATHIESON, Thomas
    Mizpah 9 Newhouse Drive
    FK1 5PE Falkirk
    Administrateur
    Mizpah 9 Newhouse Drive
    FK1 5PE Falkirk
    British42422590001
    MCCORMICK, John Robert
    17 Wellknowe Place
    Thorntonhall
    G74 5QA Glasgow
    Administrateur
    17 Wellknowe Place
    Thorntonhall
    G74 5QA Glasgow
    ScotlandBritish82210090001
    MCGOWAN, John Paul
    300
    Stirling Road
    FK5 3NJ Larbert
    Carmuirs House
    Stirlingshire
    Scotland
    Administrateur
    300
    Stirling Road
    FK5 3NJ Larbert
    Carmuirs House
    Stirlingshire
    Scotland
    United KingdomBritish183541910002
    METHVEN, John Bruce
    Northcote
    Barr Road
    TD1 3HX Galashiels
    Selkirkshire
    Administrateur
    Northcote
    Barr Road
    TD1 3HX Galashiels
    Selkirkshire
    ScotlandBritish46223280001
    MONTGOMERY, Robert
    Doublenuts
    Clowbridge
    BB11 5NX Burnley
    Administrateur
    Doublenuts
    Clowbridge
    BB11 5NX Burnley
    British57748800001
    O'TOOLE, Raymond
    49 Hall Lee Fold
    HD3 3NX Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    49 Hall Lee Fold
    HD3 3NX Huddersfield
    West Yorkshire
    British67261690001
    PELLING, William Pollock Douglas
    15 Drovers Way
    EH45 9BN Peebles
    Peeblesshire
    Administrateur
    15 Drovers Way
    EH45 9BN Peebles
    Peeblesshire
    British548980001
    SAVELLI, Mark Andre
    Victoria Road
    G42 7AD Glasgow
    197
    United Kingdom
    Administrateur
    Victoria Road
    G42 7AD Glasgow
    197
    United Kingdom
    United KingdomBritish76620360004
    SAVELLI, Mark Andre
    Flat 2
    75 Lancefield Quay
    G3 8HA Glasgow
    Administrateur
    Flat 2
    75 Lancefield Quay
    G3 8HA Glasgow
    British76620360002
    SEMPLE, Alan George
    Mains Of Hilton
    Catterline
    AB3 2UN Stonehaven
    Kincardineshire
    Scotland
    Administrateur
    Mains Of Hilton
    Catterline
    AB3 2UN Stonehaven
    Kincardineshire
    Scotland
    British71276550001
    SHARKEY, John
    44 Kiltarie Crescent
    ML6 8NL Airdrie
    Lanarkshire
    Administrateur
    44 Kiltarie Crescent
    ML6 8NL Airdrie
    Lanarkshire
    British63411450002
    SMITH, Colin
    Highcroft
    St Margarets Drive
    FK15 0DP Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Highcroft
    St Margarets Drive
    FK15 0DP Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish4397700002
    STEWART, David Black
    Carmuirs House
    300 Stirling Road
    FK5 3NJ Larbert
    Stirlingshire
    Administrateur
    Carmuirs House
    300 Stirling Road
    FK5 3NJ Larbert
    Stirlingshire
    United KingdomBritish63981860001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    06 avr. 2016
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc120411
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0