CARLTON BAKERIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARLTON BAKERIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC130761
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARLTON BAKERIES LIMITED ?

    • Fabrication de pain; fabrication de pâtisseries fraîches et de gâteaux (10710) / Industries manufacturières
    • Vente au détail de pain, pâtisseries, pâtisserie fine et confiserie en magasin spécialisé (47240) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe CARLTON BAKERIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARLTON BAKERIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FUTUREPROUD LIMITED22 mars 199122 mars 1991

    Quels sont les derniers comptes de CARLTON BAKERIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CARLTON BAKERIES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CARLTON BAKERIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de réunion finale des créanciers

    4 pages4.17(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * Units 20-25, Fife Food Centre Faraday Road Southfield Industrial Estate Glenrothes, Fife KY6 2RU* le 10 juil. 2012

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    1 pagesCO4.2(Scot)

    Nomination d'un liquidateur provisoire

    4.9(Scot)

    Avis de liquidation

    1 pages4.2(Scot)

    Nomination d'un liquidateur provisoire

    2 pages4.9(Scot)

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 avr. 2012

    État du capital au 04 avr. 2012

    • Capital: GBP 41,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de John Simpson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Steele Galloway Simpson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2006

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de CARLTON BAKERIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SIMPSON, Graeme Dewar
    Blythswood
    83 Loughbrough Road
    KY1 3DB Kirkcaldy
    Fife
    Secrétaire
    Blythswood
    83 Loughbrough Road
    KY1 3DB Kirkcaldy
    Fife
    British43361450005
    SIMPSON, Graeme Dewar
    Blythswood
    83 Loughbrough Road
    KY1 3DB Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    Blythswood
    83 Loughbrough Road
    KY1 3DB Kirkcaldy
    Fife
    ScotlandBritish43361450005
    SIMPSON, John Steele Galloway
    West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    191
    Administrateur
    West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    191
    ScotlandBritish158183380001
    MCCONAGHY, Vivienne Francis
    12 Craighall Gardens
    EH6 4RJ Edinburgh
    Secrétaire
    12 Craighall Gardens
    EH6 4RJ Edinburgh
    British1408260002
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    CURRAN, John Paul
    Strathearn 29 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Administrateur
    Strathearn 29 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    ScotlandBritish44316690001
    MCCONAGHY, Laurence Gerald
    12 Craighall Gardens
    EH6 4RJ Edinburgh
    Administrateur
    12 Craighall Gardens
    EH6 4RJ Edinburgh
    United KingdomBritish398700002
    RICHARDSON, Ian Boyd
    214 Braid Road
    EH10 6NZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    214 Braid Road
    EH10 6NZ Edinburgh
    Midlothian
    British2395150001
    SIMPSON, John Steele
    87 Loughborough Road
    KY1 3DD Kirkcaldy
    Administrateur
    87 Loughborough Road
    KY1 3DD Kirkcaldy
    ScotlandBritish527440001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    CARLTON BAKERIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 23 mars 2005
    Livré le 02 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    338 & 342 high street, kirkcaldy, fife.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 01 sept. 2004
    Livré le 07 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    50 woodside way, glenrothes.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 sept. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 04 juin 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    41 whytescauseway, kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 02 juin 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3 crossgate, cupar.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    12 whytehouse avenue, kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Bakery and whyte house, park place, kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    235 high street, kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    231 st clair street, kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    77 st clair street, kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    252 dunearn drive, kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground to rear of 24 whytehouse avenue, kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 22 mai 2003
    Livré le 29 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 07 févr. 1997
    Livré le 19 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    12 whytehouse avenue,kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 févr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 févr. 1997
    Livré le 18 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3 crossgate,cupar,fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 févr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 nov. 1996
    Livré le 25 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    25.76 square metres of 24 whytehouse avenue,kirkcaldy,fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 nov. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 sept. 1996
    Livré le 09 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    41 whytescauseway,kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 oct. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 24 sept. 1996
    Livré le 07 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    252 dunearn drive,kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 oct. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 24 sept. 1996
    Livré le 07 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    231 st clair street,kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 oct. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 24 sept. 1996
    Livré le 07 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    77 st clair street,kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 oct. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 sept. 1996
    Livré le 17 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    235 high street,kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 sept. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 sept. 1996
    Livré le 17 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The former mansion house known as the whytehouse,park place,kirkcaldy and associated bakery unit,outhouses and others all situated at park place,kirkcaldy,fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 sept. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 19 août 1996
    Livré le 26 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 juil. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 16 sept. 1991
    Livré le 24 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The mansionhouse known as whitehouse, park place, kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 17 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 09 sept. 1991
    Livré le 30 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Harold Christie Forwell and Others as Partners and Trustees for the Firm of Carlton Bakeries
    Transactions
    • 30 sept. 1991Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 sept. 1991Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 sept. 1991
    Livré le 30 sept. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Harold Christie Forwell and Others as Partner and Trustee for the Firm of Carlton Bakerie
    Transactions
    • 30 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui

    CARLTON BAKERIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 mai 2012Commencement of winding up
    21 juin 2012Conclusion of winding up
    31 mai 2012Petition date
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    provisional liquidator
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    Notesscottish-insolvency-info
    2
    DateType
    21 juin 2012Commencement of winding up
    08 juil. 2016Due to be dissolved on
    30 mars 2016Conclusion of winding up
    21 juin 2012Petition date
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    practitioner
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0