ALPHA PLUS (SCOTLAND) LIMITED

ALPHA PLUS (SCOTLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALPHA PLUS (SCOTLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC133095
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALPHA PLUS (SCOTLAND) LIMITED ?

    • Agents de commerce de machines, d'équipements industriels, de navires et d'aéronefs (46140) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Commerce de gros non spécialisé (46900) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe ALPHA PLUS (SCOTLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    110 Queen Street
    G1 3BX Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ALPHA PLUS (SCOTLAND) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ALPHA PLUS (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:form 4.26(scot) Return of final meeting
    3 pagesLIQ MISC

    Avis de réunion finale des créanciers

    7 pages4.17(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de C/O Grant Thornton Uk Llp 95 Bothwell Street Glasgow G2 7JZ à C/O Grant Thornton Uk Llp 110 Queen Street Glasgow G1 3BX le 27 oct. 2015

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    9 pages2.20B(Scot)

    Avis de passage de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.25B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    10 pages2.20B(Scot)

    Cessation de la nomination de Stephen Matthews en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Proposition de l'administrateur

    23 pages2.16B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * 10 Caputhall Road Deans Industrial Estate Livingston West Lothian EH54 8AS* le 24 sept. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juil. 2012

    État du capital au 27 juil. 2012

    • Capital: GBP 29,032.22
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2010

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de Janet Wilson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    État du capital après une attribution d'actions au 17 janv. 2011

    • Capital: GBP 29,032.22
    5 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    16 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Modifications à la charge flottante 12

    5 pages466(Scot)

    legacy

    5 pagesMG01s

    Modifications à la charge flottante 6

    5 pages466(Scot)

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    22 pagesAA

    Cessation de la nomination de Raymond Warrender en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Raymond James Warrender le 25 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de ALPHA PLUS (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BLUNDELL, Jonathan David
    58 Deanburn Park
    EH49 6HA Linlithgow
    West Lothian
    Secrétaire
    58 Deanburn Park
    EH49 6HA Linlithgow
    West Lothian
    British3206160001
    BROWNLEE, Archibald Fullarton Wilson
    Ciarnaig, 8 Lyle Green
    Golf Course Road
    EH54 8QE Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    Ciarnaig, 8 Lyle Green
    Golf Course Road
    EH54 8QE Livingston
    West Lothian
    British83989290001
    MATTHEWS, Stephen Andrew
    2 Saint Michaels Lane
    Blackness Road
    EH49 7JD Linlithgow
    West Lothian
    Secrétaire
    2 Saint Michaels Lane
    Blackness Road
    EH49 7JD Linlithgow
    West Lothian
    British55190340002
    WILSON, Janet
    Westwood Park
    Deans
    EH5 8QP Livingston
    2
    West Lothian
    Scotland
    Secrétaire
    Westwood Park
    Deans
    EH5 8QP Livingston
    2
    West Lothian
    Scotland
    BritishCustomer Services Director140380250001
    BLUNDELL, Jonathan David
    58 Deanburn Park
    EH49 6HA Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    58 Deanburn Park
    EH49 6HA Linlithgow
    West Lothian
    ScotlandBritishManager3206160001
    BLUNDELL, Kenneth
    The Sheiling
    6 St Ninians Avenue
    EH49 7BP Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    The Sheiling
    6 St Ninians Avenue
    EH49 7BP Linlithgow
    West Lothian
    BritishRetired54666140001
    BROWNLEE, Archibald Fullarton Wilson
    Ciarnaig, 8 Lyle Green
    Golf Course Road
    EH54 8QE Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    Ciarnaig, 8 Lyle Green
    Golf Course Road
    EH54 8QE Livingston
    West Lothian
    BritishFinancial Director83989290001
    MATTHEWS, Stephen Andrew
    2 Saint Michaels Lane
    Blackness Road
    EH49 7JD Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    2 Saint Michaels Lane
    Blackness Road
    EH49 7JD Linlithgow
    West Lothian
    ScotlandBritishCompany Director55190340002
    OST, Robert Alfred
    11 Rides Court
    Moulton
    NN3 7UA Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    11 Rides Court
    Moulton
    NN3 7UA Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director4664940001
    ROBERTSON, Archibald Bernard
    5 The Inches
    Dalgety Bay
    KY11 9YG Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    5 The Inches
    Dalgety Bay
    KY11 9YG Dunfermline
    Fife
    BritishCertified Accountant43154300001
    WARRENDER, Raymond James
    10 Barclay Road
    AB51 3QP Inverurie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    10 Barclay Road
    AB51 3QP Inverurie
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishDirector101912580001
    WRIGHT, John Robertson
    Ednam Mains House
    Ednam
    TD5 7QL Kelso
    Roxburghshire
    Administrateur
    Ednam Mains House
    Ednam
    TD5 7QL Kelso
    Roxburghshire
    ScotlandBritishRetired Bank Chief Executive161798090001

    ALPHA PLUS (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 20 déc. 2010
    Livré le 30 déc. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due in terms of a loan facility agreement
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • East of Scotland Investment Fund Limited
    Transactions
    • 30 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 13 janv. 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 27 oct. 2009
    Livré le 14 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    The obligations in terms of a loan agreement
    Brèves mentions
    Subjects at caputhill road, deans, livingston WLN11368.
    Personnes ayant droit
    • Hako Machines Limited
    Transactions
    • 14 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Floating charge
    Créé le 14 sept. 2007
    Livré le 20 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 20 sept. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 nov. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 05 mai 2005
    Livré le 16 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Industrial unit at lethenty mills, lethenty, inverurie.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 04 avr. 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Industrial unit at lethenty mills, lethenty, inverurie.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 19 juil. 2004
    Livré le 22 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Industrial unit at 10 caputhall road, deans industrial estate, livingston.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 mai 2004
    Livré le 02 juin 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 nov. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 oct. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 déc. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 28 oct. 2003
    Livré le 04 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Commercial premise sat lethenty mills, inverurie, aberdeenshire.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 04 nov. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignment of the benefit of a sub hire agreement
    Créé le 16 oct. 2002
    Livré le 18 oct. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The benefit of any and all hire agreements (including the benefit of any relevant guarantees) in respect of bergmann RP7700M & roll packer 091538153802.
    Personnes ayant droit
    • Ing Lease (UK) Twelve LTD.
    Transactions
    • 18 oct. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 22 févr. 2001
    Livré le 02 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Full title guarantee by way of floating charge of all the sub-hire contracts including without limitation the right to receive the sub-hire debts.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Associates Commercial Corporation Limited
    Transactions
    • 02 mars 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 oct. 1994
    Livré le 18 oct. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Warehouse at middleton hall, uphall, west lothian.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 18 oct. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 05 oct. 1994
    Livré le 20 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 20 oct. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    ALPHA PLUS (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 sept. 2013Administration ended
    14 sept. 2012Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton Uk Llp
    1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    Robert Caven
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    practitioner
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    2
    DateType
    09 sept. 2017Due to be dissolved on
    11 sept. 2013Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton Uk Llp
    1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    Robert Caven
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    practitioner
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0