PUFFIN HYDROTHERAPY POOL
Vue d'ensemble
Nom de la société | PUFFIN HYDROTHERAPY POOL |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
Numéro de société | SC133596 |
Juridiction | Écosse |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PUFFIN HYDROTHERAPY POOL ?
Adresse du siège social | Puffin Hydrotherapy Pool Ferry Road IV15 9QS Dingwall Ross Shire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PUFFIN HYDROTHERAPY POOL ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PUFFIN HYDROTHERAPY POOL ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 07 août 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 21 août 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 07 août 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour PUFFIN HYDROTHERAPY POOL ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Clifford Davison en tant que directeur le 24 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024 | 26 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Murdo Morrison Macdonald en tant qu'administrateur le 25 juil. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Rev Dr Barbara Janet Chandler en tant qu'administrateur le 25 juil. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Miss Margaret Macdonald en tant qu'administrateur le 25 juil. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Barbara Jean Manson en tant que directeur le 25 juil. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Linda Louise Kirkland en tant que directeur le 25 juil. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 août 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Statuts | 14 pages | MA | ||||||||||
Statuts | 14 pages | MA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 août 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Iona Mcgauran en tant que secrétaire le 19 juil. 2023 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Linda Kirkland en tant que secrétaire le 19 juil. 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mrs Frances Claudia Bowen en tant qu'administrateur le 15 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Blazej Andrzej Pytko en tant qu'administrateur le 15 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 27 pages | AA | ||||||||||
Statuts | 14 pages | MA | ||||||||||
Nomination de Miss Elizabeth Ann Dallas en tant qu'administrateur le 10 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Karen Fiona Deans en tant qu'administrateur le 10 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Notification de Brian Desmond Liddle en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 mars 2023 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Malcolm Ronald Laing en tant que directeur le 16 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Hugh Aberach Mackay en tant que directeur le 06 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de Hugh Aberach Mackay en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 mars 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Helen Grace Charley en tant que directeur le 28 août 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PUFFIN HYDROTHERAPY POOL ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGAURAN, Iona | Secrétaire | Boswell Road IV2 3EJ Inverness 46 Scotland | 312293220001 | |||||||
BOWEN, Frances Claudia | Administrateur | Golf Course Road IV14 9AT Strathpeffer The Cliff Scotland | Scotland | Kenyan | Physiotherapist | 312293050001 | ||||
BROWN, Margaret Beta | Administrateur | Bunchrew IV3 8TB Inverness Ladystone Farmhouse Inverness-Shire Scotland | Scotland | British | Retired | 249818600001 | ||||
CAMERON, Brian | Administrateur | Mountrich Place IV15 9RH Dingwall 3 Ross-Shire Scotland | Scotland | British | Director | 89474100001 | ||||
CHANDLER, Barbara Janet, Rev Dr | Administrateur | Lentran IV3 8RN Inverness Highland House Scotland | Scotland | Scottish | Retired | 326558460001 | ||||
DALLAS, Elizabeth Ann | Administrateur | Kessock Avenue IV3 8BB Inverness 28 Scotland | Scotland | British | Disabled | 308957820001 | ||||
DEANS, Karen Fiona | Administrateur | Lentran IV3 8RN Inverness Woodridge Scotland | Scotland | British | Carer | 308956990001 | ||||
LIDDLE, Brian Desmond | Administrateur | 39 Urquhart Road IV15 9PE Dingwall 39 Ross-Shire Scotland | Scotland | British | Retired | 210505710001 | ||||
MACDONALD, Margaret | Administrateur | Mill Road IV12 5EP Nairn Glencawdor Cottage Scotland | Scotland | Scottish | Retired | 326549360001 | ||||
MACDONALD, Murdo Morrison | Administrateur | Castle Gardens IV15 9HY Dingwall 2 Castle Gardens Scotland | Scotland | Scottish | Retired | 326571040001 | ||||
MAXWELL, John Alexander | Administrateur | Rowan Gardens Conon Bridge IV7 8FJ Dingwall 38 Scotland | Scotland | British | Solicitor | 131637720005 | ||||
MCGAURAN, Iona | Administrateur | Puffin Hydrotherapy Pool Ferry Road IV15 9QS Dingwall Ross Shire | Scotland | British | Lead Nurse | 285536030001 | ||||
PATERSON, Margaret Elizabeth | Administrateur | Craiglea Craig Road IV15 9LF Dingwall Ross Shire | Scotland | Scottish | Company Director | 32226720001 | ||||
PYTKO, Blazej Andrzej | Administrateur | Lodgehill Gate IV12 4SE Nairn 4 Scotland | Scotland | Polish | Physiotherapist | 312292600001 | ||||
ARNOTT, Mirian Marshall | Secrétaire | 46 Leachkin Drive IV3 6LG Inverness Inverness Shire | British | 4654080001 | ||||||
BLACK, Duncan Kerr Mather, Dr | Secrétaire | Brantwood St James Street IV15 9JA Dingwall Ross Shire | British | Gp | 54620580001 | |||||
CHRISTIE, James Stewart | Secrétaire | 13 Churchill Drive IV15 9RD Dingwall Ross Shire | British | 4654060001 | ||||||
KIRKLAND, Linda | Secrétaire | Puffin Hydrotherapy Pool Ferry Road IV15 9QS Dingwall Ross Shire | 261256510001 | |||||||
MACKAY, Hugh Aberach | Secrétaire | Urquhart Road IV15 9PE Dingwall 6 Ross-Shire United Kingdom | British | 161677670001 | ||||||
MACLEOD, Neil Ferguson | Secrétaire | Frensham Tulloch Avenue IV15 9TU Dingwall Ross Shire | British | 45431890001 | ||||||
BEARE, David Frank | Administrateur | Pinewood Reisk More IV18 0LN Invergordon | British | Council Officer | 32224590002 | |||||
BLACK, Duncan Kerr Mather, Dr | Administrateur | Brantwood St James Street IV15 9JA Dingwall Ross Shire | Scotland | British | Doctor | 54620580001 | ||||
BREMNER, James Walker | Administrateur | Strathmore Gairloch Crescent IV7 8BQ Conon Bridge Ross-Shire | Scotland | British | Retired | 37683510001 | ||||
BROTHERSTON, Patricia Mary | Administrateur | 44 High Street IV10 8SU Fortrose Ross Shire | British | Physiotherapist | 4654070001 | |||||
BRYANT, Jane Elizabeth Ann | Administrateur | Ard Beg Hill Of Fortrose IV10 8SG Fortrose Ross Shire | Scotland | British | Retired | 82916690001 | ||||
BUCHANAN, Margaret Annie | Administrateur | Maybank Station Road IV7 8BJ Conon Bridge Ross-Shire | British | Retired | 37683640001 | |||||
CAMERON, Isabel Fraser | Administrateur | Rosarden Upper Knockbain Road IV15 9NR Dingwall Ross & Cromarty | United Kingdom | British | Retired | 90846170001 | ||||
CAMPBELL, Anne Lesley | Administrateur | 13 Kintail Place IV15 9RL Dingwall Ross Shire | British | Company Director | 54882360001 | |||||
CHARIE, Richard Christopher | Administrateur | Broomhill House Farr IV1 2KA Inverness Invernessshire | British | Hotel Sales Manager | 44141730001 | |||||
CHARLEY, Helen Grace | Administrateur | Marine Terrace IV10 8UL Rosemarkie Ootsie Ross-Shire Scotland | Scotland | British | Retired | 200683060002 | ||||
CHRISTIE, James Stewart | Administrateur | 13 Churchill Drive IV15 9RD Dingwall Ross Shire | British | Solicitor | 4654060001 | |||||
CORBETT, Louise Christine | Administrateur | West Cottage Lettoch Farm North Kessock Inverness | British | Staff Nurse | 78065680002 | |||||
DAVIDSON, Alan John Lawson, Dr | Administrateur | Upper Knockbain Road IV15 9NR Dingwall Breda Ross-Shire | Scotland | British | Medical Practitioner | 170678400001 | ||||
DAVISON, Clifford | Administrateur | Fairburn House Urray IV6 7UT Muir Of Ord Ross-Shire | Scotland | British | Director | 407080001 | ||||
FLEMING, Carol-Ann | Administrateur | Puffin Hydrotherapy Pool Ferry Road IV15 9QS Dingwall Ross Shire | Scotland | British | Retired | 180437790002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PUFFIN HYDROTHERAPY POOL ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr Brian Desmond Liddle | 06 mars 2023 | Puffin Hydrotherapy Pool Ferry Road IV15 9QS Dingwall Ross Shire | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Hugh Aberach Mackay | 15 juil. 2021 | Urquhart Road IV15 9PE Dingwall 6 Scotland | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
Dr Helen Charley | 20 juin 2018 | The Old Mill Rosemarkie IV10 8UL Fortrose The Old Mill Ross-Shire Scotland | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
Doctor Malcolm Monteith Steven | 13 juil. 2016 | Puffin Hydrotherapy Pool Ferry Road IV15 9QS Dingwall Ross Shire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0