CALLENDAR SQUARE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCALLENDAR SQUARE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC134375
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CALLENDAR SQUARE LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe CALLENDAR SQUARE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor, Excel House
    Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CALLENDAR SQUARE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ORRMAC (NO:600) LIMITED08 oct. 199108 oct. 1991

    Quels sont les derniers comptes de CALLENDAR SQUARE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour CALLENDAR SQUARE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de réunion finale des créanciers

    2 pages4.17(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Third Floor West Edinburgh Quay 2 139 Fountainbridge Edinburgh EH3 9QG à 2nd Floor, Excel House Semple Street Edinburgh EH3 8BL le 22 févr. 2017

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Management Office Callendar Square Shopping Centre High Street Falkirk FK1 1UJ à Third Floor West Edinburgh Quay 2 139 Fountainbridge Edinburgh EH3 9QG le 06 juil. 2015

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    1 pagesCO4.2(Scot)

    Avis de liquidation

    1 pages4.2(Scot)

    legacy

    1 pagesAC93

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 nov. 2012

    État du capital au 02 nov. 2012

    • Capital: GBP 23,505,680
    SH01

    Cessation de la nomination de Mette Geddes en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    12 pagesAA

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Divers

    Section 519 statement
    2 pagesMISC

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Gabriel Mclaughlin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Glenn Maud le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Peter Saunders en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter John Saunders le 02 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gabriel Mclaughlin le 02 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Glenn Maud le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de CALLENDAR SQUARE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAUD, Glenn
    Wilton Crescent
    SW1X 8RN London
    4
    Great Britain
    Administrateur
    Wilton Crescent
    SW1X 8RN London
    4
    Great Britain
    United KingdomBritish149461800001
    GEDDES, Mette
    St. Philips Avenue
    KT4 8LA Worcester Park
    Surrey
    Secrétaire
    St. Philips Avenue
    KT4 8LA Worcester Park
    Surrey
    Danish108452870002
    JONES, John Elliott
    16 Ferguson Green
    EH21 6XB Musselburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    16 Ferguson Green
    EH21 6XB Musselburgh
    Midlothian
    British12016930002
    ORR MACQUEEN WS
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secrétaire désigné
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    900000160001
    BREISH, Abdulmagid Abdulsalam
    103 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JZ London
    Administrateur
    103 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JZ London
    Libyan British30841030001
    DICKSON, William Adam
    51 Westerlea Drive
    Bridge Of Allan
    FK9 4DQ Stirling
    Administrateur
    51 Westerlea Drive
    Bridge Of Allan
    FK9 4DQ Stirling
    British36383820001
    DOBIE, Douglas Jardine
    The Retreat
    Blackerstone
    TD11 3RY Duns
    Berwickshire
    Administrateur
    The Retreat
    Blackerstone
    TD11 3RY Duns
    Berwickshire
    ScotlandBritish12017010001
    DRUMMOND, John Stephen
    Whittinghame House
    EH41 Haddington
    East Lothian
    Administrateur
    Whittinghame House
    EH41 Haddington
    East Lothian
    British31143040001
    FROHNSDORFF, David
    Grosvenor Street
    W1K 4QG London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QG London
    17
    United Kingdom
    British117523270003
    GAYFORD, Jane Frances
    Whittinghame House
    EH41 4QA Haddington
    East Lothian
    Administrateur
    Whittinghame House
    EH41 4QA Haddington
    East Lothian
    British34733120001
    JONES, John Elliott
    16 Ferguson Green
    EH21 6XB Musselburgh
    Midlothian
    Administrateur
    16 Ferguson Green
    EH21 6XB Musselburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish12016930002
    MCGREGOR, Douglas
    11 Vorlich Drive
    Shieldhill
    FK1 2HF Falkirk
    Stirlingshire
    Administrateur
    11 Vorlich Drive
    Shieldhill
    FK1 2HF Falkirk
    Stirlingshire
    United KingdomBritish48154290001
    MCLAUGHLIN, Gabriel
    Tring Road
    Northchurch
    HP4 3TL Berkhamsted
    Hamberlins
    Hertfordshire
    Administrateur
    Tring Road
    Northchurch
    HP4 3TL Berkhamsted
    Hamberlins
    Hertfordshire
    United KingdomBritish141889290001
    MURRAY, Rodger Grant
    24 Moston Terrace
    Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Moston Terrace
    Edinburgh
    British900000170001
    ROSS, Duncan John
    2 Miller Park
    Polmont
    FK2 0UJ Falkirk
    Stirlingshire
    Administrateur
    2 Miller Park
    Polmont
    FK2 0UJ Falkirk
    Stirlingshire
    British1067350001
    SAUNDERS, Peter John
    35 Stone Yard Plumptre Street
    NG1 1JL Nottingham
    Administrateur
    35 Stone Yard Plumptre Street
    NG1 1JL Nottingham
    United KingdomBritish149140450001
    SCOTT, John Hamilton
    7 Glengyle Terrace
    Edinburgh
    Administrateur désigné
    7 Glengyle Terrace
    Edinburgh
    British900000180001
    SHAW, John
    Head Of Property Services
    Central Regional Council
    FK8 2ET Stirling
    Administrateur
    Head Of Property Services
    Central Regional Council
    FK8 2ET Stirling
    British40010120001
    TELFER, John
    Amisfield East Cottage
    Amisfield
    EH41 4PU Haddington
    East Lothian
    Administrateur
    Amisfield East Cottage
    Amisfield
    EH41 4PU Haddington
    East Lothian
    British68687530001

    CALLENDAR SQUARE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignation of rents
    Créé le 27 avr. 2006
    Livré le 04 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The companys whole entitlement to receive from the tenants and from any other relevant third party (as appropriate) the rental income of the property.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Landesbank
    Transactions
    • 04 mai 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 05 avr. 2006
    Livré le 18 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The tenants interest in the lease of the subjects known as and forming callendar shopping centre at high street, callendar riggs and kerse lane, falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Landesbank
    Transactions
    • 18 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 16 mars 2006
    Livré le 04 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    See paper apart for details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Landesbank
    Transactions
    • 04 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 15 mars 2006
    Livré le 04 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Landesbank
    Transactions
    • 04 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Rental assignation
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 20 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to the finance documents
    Brèves mentions
    The rental income relative to the tenant's interest in callendar square shopping centre, falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 20 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 18 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to the finance documents
    Brèves mentions
    The tenant's interest in the subjects known as and forming callendar shopping centre at high street, callendar riggs and kerse lane, falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 18 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 03 avr. 2002
    Livré le 11 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Callendar square shopping centre at high street, callendar riggs and kerse lane, falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 11 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 mars 2002
    Livré le 03 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 03 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 mars 1998
    Livré le 30 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in the lease over subjects at high street,callendar riggs & kerse lane,falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Falkirk Council
    Transactions
    • 30 mars 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 20 févr. 1998
    Livré le 09 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 mars 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 mars 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 20 déc. 1993
    Livré le 30 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenant's part of the lease between crc and the chargor dated 30TH april 1992 recorded grs stirling 1ST may 1992 as varied by minute of agreement between crc and the chargor adted 1ST and 3RD dec 1993 and recorded grs 20TH dec 1993 (subjects in callander square, falkirk).
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transactions
    • 30 déc. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation in security
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The chargor's whole right, title, interest and benefit in and to the missives including all of the chargor's rights relative thereto.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mars 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 01 mai 1992
    Livré le 12 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £12,000,000
    Brèves mentions
    Part of a lease over 2.12 acres and others lying generally to the south of kerse lane to the west of callendar riggs and to the north of high street all falkirk known as the callendar centre falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Abc International Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 13 janv. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 30 avr. 1992
    Livré le 14 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Abc International Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    CALLENDAR SQUARE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 avr. 2018Conclusion of winding up
    25 juin 2015Petition date
    25 juin 2015Commencement of winding up
    27 juil. 2018Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Edward Reed
    Third Floor West, Edinburgh Quay 2, 139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    practitioner
    Third Floor West, Edinburgh Quay 2, 139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Robert Alexander Henry Maxwell
    Third Floor West, Edinburgh Quay 2,139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    practitioner
    Third Floor West, Edinburgh Quay 2,139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Kenneth W Pattullo
    Atholl Exchange, Third Floor West, Quay 2, 139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    practitioner
    Atholl Exchange, Third Floor West, Quay 2, 139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0