HEALTH AND LIFECARE OPTIONS (SERVICES) LIMITED

HEALTH AND LIFECARE OPTIONS (SERVICES) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHEALTH AND LIFECARE OPTIONS (SERVICES) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC135222
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HEALTH AND LIFECARE OPTIONS (SERVICES) LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HEALTH AND LIFECARE OPTIONS (SERVICES) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o ALLIED HEALTHCARE GROUP
    Ground Floor Mill House Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HEALTH AND LIFECARE OPTIONS (SERVICES) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SCOTNURSING LIMITED25 nov. 199125 nov. 1991

    Quels sont les derniers comptes de HEALTH AND LIFECARE OPTIONS (SERVICES) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour HEALTH AND LIFECARE OPTIONS (SERVICES) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Carl Michael Brown en tant que directeur le 29 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Dr Caspaar Friedrich Trautwein en tant qu'administrateur le 29 nov. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 25 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de John Henry Whitehead en tant que directeur le 12 juin 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Carl Michael Brown en tant qu'administrateur le 12 juin 2017

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    4 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    20 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Richard Mark Preece en tant que directeur le 16 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 janv. 2016 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Richard Mark Preece en tant qu'administrateur le 15 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Mark Pethick en tant que directeur le 31 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Victoria Haynes en tant que secrétaire le 01 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 nov. 2015

    État du capital au 26 nov. 2015

    • Capital: GBP 24,286
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2015

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Timothy Mark Pethick en tant qu'administrateur le 09 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Darryn Stanley Gibson en tant que directeur le 09 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Henry Whitehead le 01 mars 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 janv. 2015

    État du capital au 07 janv. 2015

    • Capital: GBP 24,286
    SH01

    Qui sont les dirigeants de HEALTH AND LIFECARE OPTIONS (SERVICES) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TRAUTWEIN, Caspaar Friedrich, Dr
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    Administrateur
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    GermanyGerman253045720001
    DAVIES, John
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    166607990001
    HAYNES, Victoria
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    British182412280001
    HENDRY, Craig Archibald Macdonald
    2 Williamwood Park
    Netherlee
    G44 3TD Glasgow
    Secrétaire
    2 Williamwood Park
    Netherlee
    G44 3TD Glasgow
    British104826820001
    NGONDONGA, Taguma
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    171612980001
    RUSHFORTH, Douglas Alexander
    4 Ledcameroch Crescent
    G61 4AD Glasgow
    Secrétaire
    4 Ledcameroch Crescent
    G61 4AD Glasgow
    British52273580002
    RUSHFORTH, Douglas Alexander
    4 Ledcameroch Crescent
    G61 4AD Glasgow
    Secrétaire
    4 Ledcameroch Crescent
    G61 4AD Glasgow
    British52273580002
    WESTWOOD, Philip
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    Scotland
    158980650001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BLAIR, James Douglas
    2 Hillneuk Avenue
    Bearsden
    G61 3PY Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Hillneuk Avenue
    Bearsden
    G61 3PY Glasgow
    Lanarkshire
    British698040002
    BRECKENRIDGE, Jack Morton
    63 Lauderdale Gardens
    G12 9QU Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    63 Lauderdale Gardens
    G12 9QU Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish846950001
    BROWN, Carl Michael
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    Administrateur
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    EnglandBritish232841280001
    COOPER, James
    7 Kirkstyle Avenue
    ML8 5AQ Carluke
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Kirkstyle Avenue
    ML8 5AQ Carluke
    Lanarkshire
    ScotlandBritish929150002
    CURRAN, John Paul
    Strathearn 29 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Administrateur
    Strathearn 29 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    ScotlandBritish44316690001
    ELDER, Marion Catherine
    Rhanna
    4 Dunlin, East Kilbride
    G74 4RU Glasgow
    South Lanarkshire
    Administrateur
    Rhanna
    4 Dunlin, East Kilbride
    G74 4RU Glasgow
    South Lanarkshire
    ScotlandBritish127732810001
    ELLIS, Martyn Anthony
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish95749550002
    GIBSON, Darryn Stanley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomNew Zealander177930490001
    HENDRY, Craig Archibald Macdonald
    2 Williamwood Park
    Netherlee
    G44 3TD Glasgow
    Administrateur
    2 Williamwood Park
    Netherlee
    G44 3TD Glasgow
    United KingdomBritish104826820001
    HOWARD, Stuart Michael
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish160271430001
    MACKAY, Morag
    8 Lochlea Road
    G76 8PZ Glasgow
    Administrateur
    8 Lochlea Road
    G76 8PZ Glasgow
    British106433500001
    MCDERMID, Craig John
    7 Woodside Terrace
    G3 7UY Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    7 Woodside Terrace
    G3 7UY Glasgow
    Strathclyde
    British90032680001
    PANU, Stella
    Flat 19
    75 Little Britain
    EC1A 7BT London
    Administrateur
    Flat 19
    75 Little Britain
    EC1A 7BT London
    United KingdomBritish116910630001
    PETHICK, Timothy Mark
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish172197670001
    PREECE, Richard Mark
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    Administrateur
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    EnglandBritish97531900001
    RUSHFORTH, Ann Bruce
    Caerleon House
    4 Ledcameroch Crescent
    G61 4AD Bearsden
    Administrateur
    Caerleon House
    4 Ledcameroch Crescent
    G61 4AD Bearsden
    ScotlandScottish9506120004
    RUSHFORTH, Douglas Alexander
    4 Ledcameroch Crescent
    G61 4AD Glasgow
    Administrateur
    4 Ledcameroch Crescent
    G61 4AD Glasgow
    ScotlandBritish52273580002
    RUSHFORTH, Douglas Alexander
    4 Ledcameroch Crescent
    G61 4AD Glasgow
    Administrateur
    4 Ledcameroch Crescent
    G61 4AD Glasgow
    ScotlandBritish52273580002
    WESTON, Paul David James
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    Scotland
    Administrateur
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    Scotland
    United KingdomBritish61904620002
    WESTWOOD, Philip John
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    Scotland
    Administrateur
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    Scotland
    EnglandBritish164395390001
    WHITEHEAD, John Henry
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish182872850002
    YOUNG, Sandy
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    Scotland
    Administrateur
    c/o Allied Healthcare Group
    Bonnington Mill Business Centre
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Ground Floor Mill House
    Scotland
    EnglandBritish158784180001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HEALTH AND LIFECARE OPTIONS (SERVICES) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Health And Lifecare Options Limited
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Allied Healthcare Group
    Scotland
    06 avr. 2016
    Newhaven Road
    EH6 5QG Edinburgh
    Allied Healthcare Group
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Scotland
    Numéro d'enregistrementSc289431
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    HEALTH AND LIFECARE OPTIONS (SERVICES) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 06 déc. 2002
    Livré le 13 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aberdeen Asset Managers Limited
    Transactions
    • 13 déc. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 déc. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2000
    Livré le 17 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.93 hectares at erskine ferry road, old kilpatrick, dunbartonshire.
    Personnes ayant droit
    • Dunbartonshire Enterprise
    Transactions
    • 17 juil. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 déc. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 08 févr. 2000
    Livré le 21 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    46 muir street. Motherwell.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 févr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 26 janv. 2000
    Livré le 11 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    81
    Brèves mentions
    46 muir street, motherwell.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 févr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 29 nov. 1999
    Livré le 06 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 déc. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 déc. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 05 juil. 1999
    Livré le 09 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot of ground to the south east of erskine ferry road, old kilpatrick, dunbartonshire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 17 nov. 1998
    Livré le 23 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 23 nov. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 janv. 1992
    Livré le 30 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 janv. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0