WASELEY (CVS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | WASELEY (CVS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC135998 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WASELEY (CVS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Suite D, Pavilion 7 Kingshill Park Venture Drive, Arnhall Business Park AB32 6FL Westhill Aberdeenshire United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WASELEY (CVS) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WASELEY (CVS) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 déc. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 déc. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 déc. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour WASELEY (CVS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2024 | 3 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth Jonathan Sharpe le 30 avr. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2023 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2022 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robin Ronald Mills le 20 avr. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2021 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Gareth Jonathan Sharpe en tant qu'administrateur le 02 nov. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Robin Ronald Mills en tant qu'administrateur le 31 juil. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Sarah Jane Sergeant en tant que directeur le 31 juil. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2020 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2019 | 3 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Kate Dunham en tant que directeur le 31 janv. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Sarah Jane Sergeant en tant qu'administrateur le 01 déc. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018 | 3 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Alison Jane Henriksen en tant que directeur le 01 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Kate Dunham en tant qu'administrateur le 01 févr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Waseley (Cvi) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 sept. 2018 | 2 pages | PSC05 | ||
Qui sont les dirigeants de WASELEY (CVS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Guildford Street KT16 9BQ Chertsey Compass House Surrey | 136459060001 | |||||||
| LEA, Jodi | Administrateur | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | United Kingdom | British | 250369010001 | |||||
| MILLS, Robin Ronald | Administrateur | Kingshill Park Venture Drive, Arnhall Business Park AB32 6FL Westhill Suite D, Pavilion 7 Aberdeenshire United Kingdom | England | British | 264890000002 | |||||
| SHARPE, Gareth Jonathan | Administrateur | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | England | British | 289083810002 | |||||
| MASON, Timothy Charles | Secrétaire | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||
| MASON, Timothy Charles | Secrétaire | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||
| PEGG, Jane | Secrétaire | Brickyard Cottage Rushock WR9 0NS Droitwich Worcestershire | British | 111345130001 | ||||||
| WALKER, James Alan Fairley | Secrétaire | Priddeons Hadley Common EN5 5QE Barnet Hertfordshire | British | 7945280002 | ||||||
| WORKMAN, Hugh John | Secrétaire | 11 Lochend Crescent Bearsden G61 1EA Glasgow Lanarkshire | British | 40633560001 | ||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secrétaire désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| ABSALOM, Peter Lyon | Administrateur | 51 Finchdean Road PO9 6DA Rowlands Castle Hampshire | British | 28594430001 | ||||||
| BELL, Francis Joseph | Administrateur | 7x Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | United Kingdom | British | 230100002 | |||||
| BRIGGS, Trevor Holden | Administrateur | Greystone 35 Kent Road HG1 2LJ Harrogate North Yorkshire | England | British | 71533050002 | |||||
| COPLAND, Barbara | Administrateur | 6 Bayhurst Drive HA6 3SA Northwood Middlesex | British | 46002690002 | ||||||
| DAVENPORT, Donald Andrew | Administrateur | Ramsbury House 23 Badgers Hill Wentworth GU25 4SA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 13178710003 | |||||
| DAVIDSON, Elizabeth Anne | Administrateur | 604 Clarkston Road G44 3SQ Glasgow Scotland | British | 59691570001 | ||||||
| DOWNING, Roger Arthur | Administrateur | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | England | British | 164972410001 | |||||
| DUNHAM, Kate | Administrateur | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | United Kingdom | British | 255875080001 | |||||
| GALVIN, Paul Anthony | Administrateur | WR6 6LL Little Witley Landscape Worcestershire United Kingdom | England | British | 159125490001 | |||||
| GALVIN, Paul Anthony | Administrateur | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 159125490002 | |||||
| GOW, Ian, Professor | Administrateur | 1 Victoria Place FK8 2QX Stirling Stirlingshire | British | 60474520001 | ||||||
| HAY, James Robert Colqhoun | Administrateur | 53 Durnsford Avenue GU13 9TB Fleet Hampshire | British | 29441130001 | ||||||
| HAY, Kenneth John | Administrateur | 4 Ferry Orchard Cambuskenneth Stirlingshire | British | 261680001 | ||||||
| HENRIKSEN, Alison Jane | Administrateur | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | United Kingdom | British | 256400460001 | |||||
| KELLY, Peter Dennis | Administrateur | Homelands Dean Street East Farelight ME13 UPT Maidstone | British | 28594560001 | ||||||
| MAGUIRE, Peter John | Administrateur | 75 High Street Hampton In Arden B92 0AE Solihull | United Kingdom | British | 127332260001 | |||||
| MASON, Timothy Charles | Administrateur | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 12314170002 | |||||
| MCNALLY, Eric Alexander | Administrateur | Hunterhill Cottage PA2 6SU Paisley | British | 718810001 | ||||||
| MCNAUGHT, David Arthur | Administrateur | 53 Lynnhurst G71 6SA Uddingston | British | 78055790001 | ||||||
| MEE, Andy Edward | Administrateur | Loughglynn Bunstrux HP23 4HT Tring Herts | England | British | 177086470001 | |||||
| MORTIMER, David Grant | Administrateur | 86 Frenchay Road OX2 6TF Oxford Oxfordshire | British | 47770480002 | ||||||
| OWEN, Michael James | Administrateur | 13 Carden Place Aberdeen AB10 1UR Aberdeenshire | United Kingdom | British | 246105820001 | |||||
| QUEEN, Michael Joseph | Administrateur | 20 Alexander Drive Bridge Of Allan FK9 4QB Stirling Stirlingshire | British | 260270001 | ||||||
| SARSON, Ian James | Administrateur | Oak Tree Farmhouse Upper Wyke SP11 6EA St Mary Bourne | England | British | 110831940001 | |||||
| SERGEANT, Sarah Jane | Administrateur | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | United Kingdom | British | 250097760001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WASELEY (CVS) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waseley (Cvi) Limited | 06 avr. 2016 | Kingshill Park Venture Drive, Arnhall Business Park AB32 6FL Westhill Suite D, Pavilion 7 Aberdeenshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0