WOODWARD-CLYDE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWOODWARD-CLYDE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC136353
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WOODWARD-CLYDE LIMITED ?

    • Activités d'études et de conseils en ingénierie pour procédés et production industriels (71121) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe WOODWARD-CLYDE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7th Floor Aurora Building
    120-136 Bothwell Street
    G2 7EA Glasgow
    Scotland
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WOODWARD-CLYDE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THORBURN COLQUHOUN INTERNATIONAL LIMITED12 oct. 199412 oct. 1994
    THORBURN INTERNATIONAL LIMITED18 mars 199218 mars 1992
    METOTHENA LIMITED31 janv. 199231 janv. 1992

    Quels sont les derniers comptes de WOODWARD-CLYDE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 oct. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour WOODWARD-CLYDE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    11 pagesLIQ13(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 févr. 2021

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 02 oct. 2020

    6 pagesAA

    Nomination de Mrs Joanne Lucy Lang en tant qu'administrateur le 30 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Cheryl Rosalind Mccall en tant que directeur le 30 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Citypoint 2 25 Tyndrum Street Glasgow G4 0JY à 7th Floor Aurora Building 120-136 Bothwell Street Glasgow Scotland G2 7EA le 26 oct. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 sept. 2019

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Bolaji Moruf Taiwo le 14 août 2019

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 28 sept. 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Cheryl Rosalind Mccall le 30 mai 2019

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Urs Europe Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mai 2019

    2 pagesPSC05

    Modification des détails de Urs Europe Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mai 2019

    2 pagesPSC05

    Nomination de Mr Bolaji Moruf Taiwo en tant que secrétaire le 27 déc. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Patrick Paul Flaherty en tant que directeur le 04 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Cheryl Rosalind Mccall en tant qu'administrateur le 03 oct. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2017

    6 pagesAA

    Nomination de Mr David John Price en tant qu'administrateur le 21 août 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Rebecca Elizabeth Hemshall en tant que directeur le 21 août 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juin 2016

    État du capital au 07 juin 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Qui sont les dirigeants de WOODWARD-CLYDE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAIWO, Bolaji Moruf
    Aurora Building
    120-136 Bothwell Street
    G2 7EA Glasgow
    7th Floor
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    Aurora Building
    120-136 Bothwell Street
    G2 7EA Glasgow
    7th Floor
    Scotland
    Scotland
    253992880001
    LANG, Joanne Lucy
    Aurora Building
    120-136 Bothwell Street
    G2 7EA Glasgow
    7th Floor
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Aurora Building
    120-136 Bothwell Street
    G2 7EA Glasgow
    7th Floor
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishAccountant255152790001
    PRICE, David John
    Aurora Building
    120-136 Bothwell Street
    G2 7EA Glasgow
    7th Floor
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Aurora Building
    120-136 Bothwell Street
    G2 7EA Glasgow
    7th Floor
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishAccountant125983730004
    COMBER, Lawrence David
    Chalkpit Terrace
    RH4 1HX Dorking
    12
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chalkpit Terrace
    RH4 1HX Dorking
    12
    Surrey
    United Kingdom
    BritishFinancial Controller134954060001
    ELLIOTT FREY, Andrew
    5 Combemartin Road
    Southfields
    SW18 5PP London
    Secrétaire
    5 Combemartin Road
    Southfields
    SW18 5PP London
    BritishAccountant83330850002
    MACKENZIE, Alan Lovat
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    Secrétaire
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    BritishChartered Accountant62414920001
    MONAGHAN, Paul
    18 Hartshill Close
    Hillingdon
    UB10 9LH Uxbridge
    Middlesex
    Secrétaire
    18 Hartshill Close
    Hillingdon
    UB10 9LH Uxbridge
    Middlesex
    BritishAccountant59170960001
    PARRY-JONES, Alan
    243 West George Street
    G2 4QE Glasgow
    Kinneil House
    Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    243 West George Street
    G2 4QE Glasgow
    Kinneil House
    Lanarkshire
    Scotland
    158420100001
    PORTER, Derek
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    Secrétaire
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    British47585310001
    BLP SECRETARIES LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5SE Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    130 St Vincent Street
    G2 5SE Glasgow
    Lanarkshire
    78293470001
    QUILL SERVE LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Secrétaire désigné
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    900000590001
    AINSWORTH, Kent
    14 Acacia Avenue
    94904 Kentfield
    California
    Usa
    Administrateur
    14 Acacia Avenue
    94904 Kentfield
    California
    Usa
    AmericanVp Cfo62413530001
    BEAMAN, John Quentin
    Bewlridge House
    Flimwell Grange
    Hadhurst
    Sussex
    Administrateur
    Bewlridge House
    Flimwell Grange
    Hadhurst
    Sussex
    BritishEngineer340600001
    BENNISON, David James
    84 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UL Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    84 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UL Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector102667530001
    BETTENBUHL, Volker Helmut
    Gartenstrasse
    65812 Bad Soden Am Taunus
    10
    Germany
    Administrateur
    Gartenstrasse
    65812 Bad Soden Am Taunus
    10
    Germany
    GermanyGermanDirector135135880001
    BRADLEY, Michael Henry
    Paternoster House Barnhall Road
    Tolleshunt Knights
    CM9 8HA Maldon
    Essex
    Administrateur
    Paternoster House Barnhall Road
    Tolleshunt Knights
    CM9 8HA Maldon
    Essex
    BritishChartered Engineer43768390002
    DEACON, John Charlesworth
    Flat 6 Astonbury Manor
    Aston Lane Aston
    SG2 7EH Stevenage
    Hertfordshire
    Administrateur
    Flat 6 Astonbury Manor
    Aston Lane Aston
    SG2 7EH Stevenage
    Hertfordshire
    EnglandBritishCivil Engineer122742230001
    DUNN, Michael John Arnold
    Walnut Acre Tandridge Road
    CR6 9LS Warlingham
    Surrey
    Administrateur
    Walnut Acre Tandridge Road
    CR6 9LS Warlingham
    Surrey
    BritishCivil Engineer11704470001
    ELLIOTT FREY, Andrew
    5 Combemartin Road
    Southfields
    SW18 5PP London
    Administrateur
    5 Combemartin Road
    Southfields
    SW18 5PP London
    United KingdomBritishAccountant83330850002
    FLAHERTY, Patrick Paul
    25 Tyndrum Street
    G4 0JY Glasgow
    Citypoint 2
    Administrateur
    25 Tyndrum Street
    G4 0JY Glasgow
    Citypoint 2
    United KingdomBritishChief Executive Uk & Ireland64396600002
    HEMSHALL, Rebecca Elizabeth
    25 Tyndrum Street
    G4 0JY Glasgow
    Citypoint 2
    Administrateur
    25 Tyndrum Street
    G4 0JY Glasgow
    Citypoint 2
    EnglandBritishFinance Director196043500001
    HORGAN, John Bernard Gerard
    25 Tyndrum Street
    G4 0JY Glasgow
    Citypoint 2
    Scotland
    Administrateur
    25 Tyndrum Street
    G4 0JY Glasgow
    Citypoint 2
    Scotland
    EnglandBritishEngineer9905560002
    MACKENZIE, Alan Lovat
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    Administrateur
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    ScotlandBritishChartered Accountant62414920001
    MARRETT, Abraham Varghese
    Warrawee Avenue
    2074 Warrawee
    16
    Nsw
    Australia
    Administrateur
    Warrawee Avenue
    2074 Warrawee
    16
    Nsw
    Australia
    AustraliaAustralianAccountant176139550001
    MCCALL, Cheryl Rosalind
    Aurora Building
    120-136 Bothwell Street
    G2 7EA Glasgow
    7th Floor
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Aurora Building
    120-136 Bothwell Street
    G2 7EA Glasgow
    7th Floor
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritishCompany Director174693580001
    MENZIES, Andrew Garland
    2 Academy Road
    KA12 8RL Irvine
    Ayrshire
    Administrateur
    2 Academy Road
    KA12 8RL Irvine
    Ayrshire
    BritishChartered Accountant61427630001
    MILLER, James Raymond
    59 Broadway Court
    The Broadway
    SW19 1RG Wimbledon
    London
    Administrateur
    59 Broadway Court
    The Broadway
    SW19 1RG Wimbledon
    London
    AmericanBusiness Executive85573230005
    MONAGHAN, Paul
    18 Hartshill Close
    Hillingdon
    UB10 9LH Uxbridge
    Middlesex
    Administrateur
    18 Hartshill Close
    Hillingdon
    UB10 9LH Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritishAccountant59170960001
    PORTER, Derek
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    Administrateur
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    United KingdomBritishChartered Accountant47585310001
    REID, William Mitchell
    Dalzell Stables
    Manse Road
    ML1 2DF Motherwell
    Administrateur
    Dalzell Stables
    Manse Road
    ML1 2DF Motherwell
    United KingdomBritishEngineer338690001
    RICHARDS, Michael Charles
    Box Tree House
    Beverley Lane
    KT2 7EE Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    Box Tree House
    Beverley Lane
    KT2 7EE Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishDirector98937350003
    THORBURN, John Quarrell
    Strathdene
    62 Townhead Street
    ML10 6DJ Strathaven
    Lanarkshire
    Administrateur
    Strathdene
    62 Townhead Street
    ML10 6DJ Strathaven
    Lanarkshire
    ScotlandBritishEngineer138890001
    WOTHERSPOON, Ian Andrew
    31 Goose Green
    RG27 9QY Hook
    Hampshire
    Administrateur
    31 Goose Green
    RG27 9QY Hook
    Hampshire
    BritishChartered Engineer53171850001
    QUILL FORM LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Administrateur désigné
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    900000580001
    QUILL SERVE LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Administrateur désigné
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    900000590001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WOODWARD-CLYDE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Urs Europe Ltd
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement03678568
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    WOODWARD-CLYDE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 25 juil. 1996
    Livré le 31 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 sept. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 25 juil. 1996
    Livré le 31 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Murray Ventures PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 sept. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 25 juil. 1996
    Livré le 31 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 sept. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 24 mai 1993
    Livré le 09 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 09 juin 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 sept. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    WOODWARD-CLYDE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 sept. 2023Due to be dissolved on
    04 févr. 2021Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0