WOODWARD-CLYDE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | WOODWARD-CLYDE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC136353 |
Juridiction | Écosse |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WOODWARD-CLYDE LIMITED ?
Adresse du siège social | 7th Floor Aurora Building 120-136 Bothwell Street G2 7EA Glasgow Scotland Scotland |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WOODWARD-CLYDE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 02 oct. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour WOODWARD-CLYDE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 11 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 02 oct. 2020 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Joanne Lucy Lang en tant qu'administrateur le 30 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Cheryl Rosalind Mccall en tant que directeur le 30 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Citypoint 2 25 Tyndrum Street Glasgow G4 0JY à 7th Floor Aurora Building 120-136 Bothwell Street Glasgow Scotland G2 7EA le 26 oct. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 sept. 2019 | 6 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Bolaji Moruf Taiwo le 14 août 2019 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 sept. 2018 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Cheryl Rosalind Mccall le 30 mai 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des détails de Urs Europe Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mai 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Modification des détails de Urs Europe Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mai 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Nomination de Mr Bolaji Moruf Taiwo en tant que secrétaire le 27 déc. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Patrick Paul Flaherty en tant que directeur le 04 oct. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Cheryl Rosalind Mccall en tant qu'administrateur le 03 oct. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr David John Price en tant qu'administrateur le 21 août 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rebecca Elizabeth Hemshall en tant que directeur le 21 août 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de WOODWARD-CLYDE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIWO, Bolaji Moruf | Secrétaire | Aurora Building 120-136 Bothwell Street G2 7EA Glasgow 7th Floor Scotland Scotland | 253992880001 | |||||||
LANG, Joanne Lucy | Administrateur | Aurora Building 120-136 Bothwell Street G2 7EA Glasgow 7th Floor Scotland Scotland | United Kingdom | British | Accountant | 255152790001 | ||||
PRICE, David John | Administrateur | Aurora Building 120-136 Bothwell Street G2 7EA Glasgow 7th Floor Scotland Scotland | United Kingdom | British | Accountant | 125983730004 | ||||
COMBER, Lawrence David | Secrétaire | Chalkpit Terrace RH4 1HX Dorking 12 Surrey United Kingdom | British | Financial Controller | 134954060001 | |||||
ELLIOTT FREY, Andrew | Secrétaire | 5 Combemartin Road Southfields SW18 5PP London | British | Accountant | 83330850002 | |||||
MACKENZIE, Alan Lovat | Secrétaire | 8 Roxburgh Drive Bearsden G61 3LH Glasgow | British | Chartered Accountant | 62414920001 | |||||
MONAGHAN, Paul | Secrétaire | 18 Hartshill Close Hillingdon UB10 9LH Uxbridge Middlesex | British | Accountant | 59170960001 | |||||
PARRY-JONES, Alan | Secrétaire | 243 West George Street G2 4QE Glasgow Kinneil House Lanarkshire Scotland | 158420100001 | |||||||
PORTER, Derek | Secrétaire | Mayfield Tandlehill Road PA10 2DD Kilbarchan Renfrewshire | British | 47585310001 | ||||||
BLP SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 130 St Vincent Street G2 5SE Glasgow Lanarkshire | 78293470001 | |||||||
QUILL SERVE LIMITED | Secrétaire désigné | 249 West George Street G2 4RB Glasgow | 900000590001 | |||||||
AINSWORTH, Kent | Administrateur | 14 Acacia Avenue 94904 Kentfield California Usa | American | Vp Cfo | 62413530001 | |||||
BEAMAN, John Quentin | Administrateur | Bewlridge House Flimwell Grange Hadhurst Sussex | British | Engineer | 340600001 | |||||
BENNISON, David James | Administrateur | 84 Tyne Crescent Brickhill MK41 7UL Bedford Bedfordshire | England | British | Director | 102667530001 | ||||
BETTENBUHL, Volker Helmut | Administrateur | Gartenstrasse 65812 Bad Soden Am Taunus 10 Germany | Germany | German | Director | 135135880001 | ||||
BRADLEY, Michael Henry | Administrateur | Paternoster House Barnhall Road Tolleshunt Knights CM9 8HA Maldon Essex | British | Chartered Engineer | 43768390002 | |||||
DEACON, John Charlesworth | Administrateur | Flat 6 Astonbury Manor Aston Lane Aston SG2 7EH Stevenage Hertfordshire | England | British | Civil Engineer | 122742230001 | ||||
DUNN, Michael John Arnold | Administrateur | Walnut Acre Tandridge Road CR6 9LS Warlingham Surrey | British | Civil Engineer | 11704470001 | |||||
ELLIOTT FREY, Andrew | Administrateur | 5 Combemartin Road Southfields SW18 5PP London | United Kingdom | British | Accountant | 83330850002 | ||||
FLAHERTY, Patrick Paul | Administrateur | 25 Tyndrum Street G4 0JY Glasgow Citypoint 2 | United Kingdom | British | Chief Executive Uk & Ireland | 64396600002 | ||||
HEMSHALL, Rebecca Elizabeth | Administrateur | 25 Tyndrum Street G4 0JY Glasgow Citypoint 2 | England | British | Finance Director | 196043500001 | ||||
HORGAN, John Bernard Gerard | Administrateur | 25 Tyndrum Street G4 0JY Glasgow Citypoint 2 Scotland | England | British | Engineer | 9905560002 | ||||
MACKENZIE, Alan Lovat | Administrateur | 8 Roxburgh Drive Bearsden G61 3LH Glasgow | Scotland | British | Chartered Accountant | 62414920001 | ||||
MARRETT, Abraham Varghese | Administrateur | Warrawee Avenue 2074 Warrawee 16 Nsw Australia | Australia | Australian | Accountant | 176139550001 | ||||
MCCALL, Cheryl Rosalind | Administrateur | Aurora Building 120-136 Bothwell Street G2 7EA Glasgow 7th Floor Scotland Scotland | England | British | Company Director | 174693580001 | ||||
MENZIES, Andrew Garland | Administrateur | 2 Academy Road KA12 8RL Irvine Ayrshire | British | Chartered Accountant | 61427630001 | |||||
MILLER, James Raymond | Administrateur | 59 Broadway Court The Broadway SW19 1RG Wimbledon London | American | Business Executive | 85573230005 | |||||
MONAGHAN, Paul | Administrateur | 18 Hartshill Close Hillingdon UB10 9LH Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | Accountant | 59170960001 | ||||
PORTER, Derek | Administrateur | Mayfield Tandlehill Road PA10 2DD Kilbarchan Renfrewshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 47585310001 | ||||
REID, William Mitchell | Administrateur | Dalzell Stables Manse Road ML1 2DF Motherwell | United Kingdom | British | Engineer | 338690001 | ||||
RICHARDS, Michael Charles | Administrateur | Box Tree House Beverley Lane KT2 7EE Kingston Upon Thames Surrey | British | Director | 98937350003 | |||||
THORBURN, John Quarrell | Administrateur | Strathdene 62 Townhead Street ML10 6DJ Strathaven Lanarkshire | Scotland | British | Engineer | 138890001 | ||||
WOTHERSPOON, Ian Andrew | Administrateur | 31 Goose Green RG27 9QY Hook Hampshire | British | Chartered Engineer | 53171850001 | |||||
QUILL FORM LIMITED | Administrateur désigné | 249 West George Street G2 4RB Glasgow | 900000580001 | |||||||
QUILL SERVE LIMITED | Administrateur désigné | 249 West George Street G2 4RB Glasgow | 900000590001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WOODWARD-CLYDE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urs Europe Ltd | 06 avr. 2016 | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
WOODWARD-CLYDE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Bond & floating charge | Créé le 25 juil. 1996 Livré le 31 juil. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Créé le 25 juil. 1996 Livré le 31 juil. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Créé le 25 juil. 1996 Livré le 31 juil. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Floating charge | Créé le 24 mai 1993 Livré le 09 juin 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
|
WOODWARD-CLYDE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0