THE POVERTY ALLIANCE
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE POVERTY ALLIANCE |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | SC136689 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE POVERTY ALLIANCE ?
| Adresse du siège social | Standard Building 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE POVERTY ALLIANCE ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE POVERTY ALLIANCE ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 16 févr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 02 mars 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 16 févr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE POVERTY ALLIANCE ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Innocent Jakisa en tant que directeur le 21 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Emma Louise Jackson en tant que directeur le 21 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Marie Ward en tant que directeur le 21 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jimmy Wilson en tant que directeur le 21 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2025 | 34 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mhairi Snowden en tant que directeur le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Mhoraig Green le 05 sept. 2025 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Miss Ellie Sophie Florence Wagstaff en tant qu'administrateur le 28 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bridget Ann Ashrowan en tant que directeur le 28 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alisa Mary Mackenzie en tant que directeur le 28 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Statuts | 37 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024 | 34 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert James Gowans en tant qu'administrateur le 24 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Mhairi Snowden en tant qu'administrateur le 24 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Kim Dams en tant qu'administrateur le 24 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Joy Mary Gillespie en tant qu'administrateur le 24 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Angela Moohan en tant qu'administrateur le 24 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Trishna Devi Singh en tant que directeur le 24 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Uzma Khan en tant que directeur le 24 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Shirley Grieve en tant que directeur le 24 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Hugh Foy en tant que directeur le 24 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023 | 30 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de THE POVERTY ALLIANCE ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLY, Peter Gerard | Secrétaire | 35 Camphill Avenue G41 3AX Glasgow Flat 1-2 United Kingdom | British | 77325210002 | ||||||
| BALDWIN, Sharon | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building Scotland | Scotland | British | 277489450001 | |||||
| CHISHOLM, Mhoraig Green | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building Scotland | Scotland | Scottish | 292181800002 | |||||
| DAMS, Kim | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building Scotland | United Kingdom | German | 318687610001 | |||||
| GILLESPIE, Joy Mary | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building Scotland | Scotland | British | 206085130001 | |||||
| GOWANS, Robert James | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building Scotland | Scotland | British | 318688340001 | |||||
| JONES, Polly Gemma | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building Scotland | Scotland | British | 291879240001 | |||||
| LYONS, Susan Jane | Administrateur | Dalcross IV2 7JQ Inverness Morayhill Inverness-Shire Scotland | Scotland | British | 158923090001 | |||||
| MCKECHNIE, Kirsty Seonaid | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building Scotland | Scotland | Scottish | 205997370001 | |||||
| MOOHAN, Angela | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building Scotland | Scotland | Scottish | 153050460001 | |||||
| WAGSTAFF, Ellie Sophie Florence | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building Scotland | Scotland | British | 334211140001 | |||||
| KILLEEN, Damian | Secrétaire | 21 Bedford Terrace Joppa EH15 2EJ Edinburgh Midlothian | British | 1422950001 | ||||||
| MILNE, James Scott | Secrétaire | 181a Lochee Road DD2 2ND Dundee Angus | British | 65152220002 | ||||||
| ADAM, Ruth Katherine | Administrateur | 162 Buchanan Street G1 2LL Glasgow | British | 64063610001 | ||||||
| ANDERSON, John | Administrateur | 25 Dalnair Street G38 5D Glasgow | British | 211960001 | ||||||
| ANWAR, Anela | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building | Scotland | British | 121090230001 | |||||
| ARCHIBALD, Susan | Administrateur | Jamphlars Place Cardenden KY5 0NT Lochgelly 16 Fife Scotland | Scotland | Scottish | 125717660002 | |||||
| ASHROWAN, Bridget Ann, Ms. | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building Scotland | United Kingdom | British | 179087720001 | |||||
| ATHERTON, Graham | Administrateur | 23 Grange Road EH9 1UQ Edinburgh | British | 91969730001 | ||||||
| BAILEY, Nick, Dr | Administrateur | 94 Beechwood Drive Broomhill G11 7HH Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 119122900001 | |||||
| BLACK, David | Administrateur | 162 Buchanan Street G1 2LL Glasgow Lanarkshire | British | 24992710001 | ||||||
| BOYLE, James | Administrateur | Dumbarton Road Old Kilpatrick G60 5LJ West Dumbartonshire 268 | Scotland | British | 136248680001 | |||||
| BOYLE, James | Administrateur | Dumbarton Road Old Kilpatrick G60 5LJ West Dumbartonshire 268 | Scotland | British | 136248680001 | |||||
| BURNS, Henry James Gerard, Dr | Administrateur | 162 Buchanan Street G1 2LL Glasgow Scotland | British | 49354850002 | ||||||
| CARLIN, Louise Elizabeth Anne | Administrateur | Craigholme 63 Dalziel Drive G41 4NY Glasgow | Scotland | British | 89111690001 | |||||
| CHAPLIN, Brian | Administrateur | Corner House Garrabost HS2 0PW Isle Of Lewis | British | 72781330001 | ||||||
| CRAISE, Lelsey Anne | Administrateur | 162 Buchanan Street G1 2LL Glasgow | British | 48631800001 | ||||||
| CULLEN, Mary | Administrateur | 162 162 Buchanan Street G52 4EG Glasgow | British | 45043370002 | ||||||
| DAVIS, Marion | Administrateur | 20 Irvine Place FK8 1BZ Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 126371140001 | |||||
| DICKIE, John Michael | Administrateur | 11a Kenmure Avenue EH8 7HD Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 101303300001 | |||||
| DICKSON, Eilidh Louise | Administrateur | 3rd Floor Front 102 Hope Street G2 6PH Glasgow Standard Building Scotland | Scotland | British | 261340890001 | |||||
| DONNELLY, Anne | Administrateur | 162 Buchanan St G1 2LL Glasgow | British | 44234870001 | ||||||
| ECCLES, Samantha Louise | Administrateur | 15 (0/2) Leven Street G41 2SB Pollockshields Glasgow | British | 101303280001 | ||||||
| ELSLEY, Susan, Dr | Administrateur | 23 Marlborough Street EH15 2BD Edinburgh Lothian | Scotland | British | 87824760001 | |||||
| ERSKINE, Angus Robert | Administrateur | 162 Buchanan Street G1 2LL Glasgow | British | 45043460002 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE POVERTY ALLIANCE ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 18 févr. 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0