THE POVERTY ALLIANCE

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE POVERTY ALLIANCE
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société SC136689
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE POVERTY ALLIANCE ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe THE POVERTY ALLIANCE ?

    Adresse du siège social
    Standard Building 3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE POVERTY ALLIANCE ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STRATHCLYDE POVERTY ALLIANCE18 févr. 199218 févr. 1992

    Quels sont les derniers comptes de THE POVERTY ALLIANCE ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE POVERTY ALLIANCE ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au16 févr. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 mars 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au16 févr. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour THE POVERTY ALLIANCE ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Innocent Jakisa en tant que directeur le 21 nov. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Emma Louise Jackson en tant que directeur le 21 nov. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Marie Ward en tant que directeur le 21 nov. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jimmy Wilson en tant que directeur le 21 nov. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2025

    34 pagesAA

    Cessation de la nomination de Mhairi Snowden en tant que directeur le 30 sept. 2025

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Mhoraig Green le 05 sept. 2025

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Miss Ellie Sophie Florence Wagstaff en tant qu'administrateur le 28 févr. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bridget Ann Ashrowan en tant que directeur le 28 févr. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alisa Mary Mackenzie en tant que directeur le 28 févr. 2025

    1 pagesTM01

    Statuts

    37 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024

    34 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Robert James Gowans en tant qu'administrateur le 24 nov. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Mhairi Snowden en tant qu'administrateur le 24 nov. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Kim Dams en tant qu'administrateur le 24 nov. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Joy Mary Gillespie en tant qu'administrateur le 24 nov. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Angela Moohan en tant qu'administrateur le 24 nov. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Trishna Devi Singh en tant que directeur le 24 nov. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Uzma Khan en tant que directeur le 24 nov. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Shirley Grieve en tant que directeur le 24 nov. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Hugh Foy en tant que directeur le 24 nov. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023

    30 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de THE POVERTY ALLIANCE ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KELLY, Peter Gerard
    35 Camphill Avenue
    G41 3AX Glasgow
    Flat 1-2
    United Kingdom
    Secrétaire
    35 Camphill Avenue
    G41 3AX Glasgow
    Flat 1-2
    United Kingdom
    British77325210002
    BALDWIN, Sharon
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    ScotlandBritish277489450001
    CHISHOLM, Mhoraig Green
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    ScotlandScottish292181800002
    DAMS, Kim
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    United KingdomGerman318687610001
    GILLESPIE, Joy Mary
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    ScotlandBritish206085130001
    GOWANS, Robert James
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    ScotlandBritish318688340001
    JONES, Polly Gemma
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    ScotlandBritish291879240001
    LYONS, Susan Jane
    Dalcross
    IV2 7JQ Inverness
    Morayhill
    Inverness-Shire
    Scotland
    Administrateur
    Dalcross
    IV2 7JQ Inverness
    Morayhill
    Inverness-Shire
    Scotland
    ScotlandBritish158923090001
    MCKECHNIE, Kirsty Seonaid
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    ScotlandScottish205997370001
    MOOHAN, Angela
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    ScotlandScottish153050460001
    WAGSTAFF, Ellie Sophie Florence
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    ScotlandBritish334211140001
    KILLEEN, Damian
    21 Bedford Terrace
    Joppa
    EH15 2EJ Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    21 Bedford Terrace
    Joppa
    EH15 2EJ Edinburgh
    Midlothian
    British1422950001
    MILNE, James Scott
    181a Lochee Road
    DD2 2ND Dundee
    Angus
    Secrétaire
    181a Lochee Road
    DD2 2ND Dundee
    Angus
    British65152220002
    ADAM, Ruth Katherine
    162 Buchanan Street
    G1 2LL Glasgow
    Administrateur
    162 Buchanan Street
    G1 2LL Glasgow
    British64063610001
    ANDERSON, John
    25 Dalnair Street
    G38 5D Glasgow
    Administrateur
    25 Dalnair Street
    G38 5D Glasgow
    British211960001
    ANWAR, Anela
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    ScotlandBritish121090230001
    ARCHIBALD, Susan
    Jamphlars Place
    Cardenden
    KY5 0NT Lochgelly
    16
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    Jamphlars Place
    Cardenden
    KY5 0NT Lochgelly
    16
    Fife
    Scotland
    ScotlandScottish125717660002
    ASHROWAN, Bridget Ann, Ms.
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    United KingdomBritish179087720001
    ATHERTON, Graham
    23 Grange Road
    EH9 1UQ Edinburgh
    Administrateur
    23 Grange Road
    EH9 1UQ Edinburgh
    British91969730001
    BAILEY, Nick, Dr
    94 Beechwood Drive
    Broomhill
    G11 7HH Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    94 Beechwood Drive
    Broomhill
    G11 7HH Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish119122900001
    BLACK, David
    162 Buchanan Street
    G1 2LL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    162 Buchanan Street
    G1 2LL Glasgow
    Lanarkshire
    British24992710001
    BOYLE, James
    Dumbarton Road
    Old Kilpatrick
    G60 5LJ West Dumbartonshire
    268
    Administrateur
    Dumbarton Road
    Old Kilpatrick
    G60 5LJ West Dumbartonshire
    268
    ScotlandBritish136248680001
    BOYLE, James
    Dumbarton Road
    Old Kilpatrick
    G60 5LJ West Dumbartonshire
    268
    Administrateur
    Dumbarton Road
    Old Kilpatrick
    G60 5LJ West Dumbartonshire
    268
    ScotlandBritish136248680001
    BURNS, Henry James Gerard, Dr
    162 Buchanan Street
    G1 2LL Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    162 Buchanan Street
    G1 2LL Glasgow
    Scotland
    British49354850002
    CARLIN, Louise Elizabeth Anne
    Craigholme
    63 Dalziel Drive
    G41 4NY Glasgow
    Administrateur
    Craigholme
    63 Dalziel Drive
    G41 4NY Glasgow
    ScotlandBritish89111690001
    CHAPLIN, Brian
    Corner House
    Garrabost
    HS2 0PW Isle Of Lewis
    Administrateur
    Corner House
    Garrabost
    HS2 0PW Isle Of Lewis
    British72781330001
    CRAISE, Lelsey Anne
    162 Buchanan Street
    G1 2LL Glasgow
    Administrateur
    162 Buchanan Street
    G1 2LL Glasgow
    British48631800001
    CULLEN, Mary
    162 162 Buchanan Street
    G52 4EG Glasgow
    Administrateur
    162 162 Buchanan Street
    G52 4EG Glasgow
    British45043370002
    DAVIS, Marion
    20 Irvine Place
    FK8 1BZ Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    20 Irvine Place
    FK8 1BZ Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritish126371140001
    DICKIE, John Michael
    11a Kenmure Avenue
    EH8 7HD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    11a Kenmure Avenue
    EH8 7HD Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish101303300001
    DICKSON, Eilidh Louise
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    Administrateur
    3rd Floor Front
    102 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Scotland
    ScotlandBritish261340890001
    DONNELLY, Anne
    162 Buchanan St
    G1 2LL Glasgow
    Administrateur
    162 Buchanan St
    G1 2LL Glasgow
    British44234870001
    ECCLES, Samantha Louise
    15 (0/2) Leven Street
    G41 2SB Pollockshields
    Glasgow
    Administrateur
    15 (0/2) Leven Street
    G41 2SB Pollockshields
    Glasgow
    British101303280001
    ELSLEY, Susan, Dr
    23 Marlborough Street
    EH15 2BD Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    23 Marlborough Street
    EH15 2BD Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish87824760001
    ERSKINE, Angus Robert
    162 Buchanan Street
    G1 2LL Glasgow
    Administrateur
    162 Buchanan Street
    G1 2LL Glasgow
    British45043460002

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE POVERTY ALLIANCE ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    18 févr. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0