MERIDIAN SALMON FARMS (ARGYLL) LIMITED

MERIDIAN SALMON FARMS (ARGYLL) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMERIDIAN SALMON FARMS (ARGYLL) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC137019
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MERIDIAN SALMON FARMS (ARGYLL) LIMITED ?

    • Aquaculture marine (03210) / Agriculture, sylviculture et pêche

    Où se situe MERIDIAN SALMON FARMS (ARGYLL) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Mowi Scotland Limited 1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Fife
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MERIDIAN SALMON FARMS (ARGYLL) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LAKELAND MARINE FARM LIMITED27 avr. 199227 avr. 1992
    LEDGE 109 LIMITED09 mars 199209 mars 1992

    Quels sont les derniers comptes de MERIDIAN SALMON FARMS (ARGYLL) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour MERIDIAN SALMON FARMS (ARGYLL) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 02 mars 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge SC1370190019 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Patricia Anne Duzinkewycz en tant que secrétaire le 09 mars 2022

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Lorraine Elizabeth Thompson en tant que secrétaire le 09 mars 2022

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Gideon Macdonald Pringle en tant que directeur le 09 mars 2020

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Mowi Scotland Ltd 1st Floor Admiralty Park Ardmiralty Road Rosyth Fife KY11 2YW Scotland à Mowi Scotland Limited 1st Floor Admiralty Park Admiralty Road Rosyth Fife KY11 2YW le 09 mars 2020

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Marine Harvest Scotland 1st Floor Admiralty Park Admiralty Road Rosyth Fife KY11 2YW à Mowi Scotland Ltd 1st Floor Admiralty Park Ardmiralty Road Rosyth Fife KY11 2YW le 09 mars 2020

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Piotr Kapinos en tant qu'administrateur le 19 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    14 pagesAA

    Notification de Dnb Bank Asa en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 juil. 2017

    1 pagesPSC02

    Qui sont les dirigeants de MERIDIAN SALMON FARMS (ARGYLL) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUZINKEWYCZ, Patricia Anne
    1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Mowi Scotland Limited
    Fife
    Scotland
    Secrétaire
    1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Mowi Scotland Limited
    Fife
    Scotland
    293382620001
    HADFIELD, Benjamin
    1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Mowi Scotland Limited
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Mowi Scotland Limited
    Fife
    Scotland
    NorwayBritish204214080001
    KAPINOS, Piotr
    1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Mowi Scotland Limited
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Mowi Scotland Limited
    Fife
    Scotland
    ScotlandPolish243484720001
    BENTLEY, James Alan
    4 Chelsea Court
    Ackenthwaite
    LA7 7DJ Milnthorpe
    Cumbria
    Secrétaire
    4 Chelsea Court
    Ackenthwaite
    LA7 7DJ Milnthorpe
    Cumbria
    British25573490001
    THOMPSON, Lorraine Elizabeth
    1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Mowi Scotland Limited
    Fife
    Scotland
    Secrétaire
    1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Mowi Scotland Limited
    Fife
    Scotland
    183546380001
    LC SECRETARIES LIMITED
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Aberdeenshire
    112802860001
    LEDINGHAM CHALMERS
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Secrétaire désigné
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    900003330001
    LEDINGHAM CHALMERS
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Secrétaire désigné
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    900003330001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    112938080001
    BLAIR, Colin Ian
    Fernoch Crescent
    PA31 8AE Lochgilphead
    9
    Argyll
    United Kingdom
    Administrateur
    Fernoch Crescent
    PA31 8AE Lochgilphead
    9
    Argyll
    United Kingdom
    United KingdomScottish83104090001
    HARPLEY, Christopher, Dr
    Quarry Rise Quarry Lane
    Kelsall
    CW6 0PD Tarporley
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Quarry Rise Quarry Lane
    Kelsall
    CW6 0PD Tarporley
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish25569910001
    IRVING, Paul Barrie
    Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Little Oak
    Cumbria
    United Kingdom
    Administrateur
    Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Little Oak
    Cumbria
    United Kingdom
    United KingdomBritish24916240001
    IRVING, Paul Barrie
    Little Oak,Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    Little Oak,Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish24916240001
    LAIRD, Lindsay Margaret, Dr
    Den O'Howie
    Ellon
    AB41 8QT Aberdeen
    Administrateur
    Den O'Howie
    Ellon
    AB41 8QT Aberdeen
    British24081410001
    LISTON, William Munro
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Administrateur
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    United KingdomBritish58492580002
    MCINTOSH, Kenneth James
    c/o Marine Harvest Scotland
    Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    1st Floor
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    c/o Marine Harvest Scotland
    Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    1st Floor
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritish124854160002
    MYRSETH, Bjorn
    Riplegarden 40
    N 5031 Laksevaag
    Norway
    Administrateur
    Riplegarden 40
    N 5031 Laksevaag
    Norway
    NorwayNorwegian43530500001
    PRINGLE, Gideon Macdonald
    1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Mowi Scotland Limited
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Mowi Scotland Limited
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritish233892160001
    SMART, Geoffrey Richard, Dr
    Redcot Kingston St Mary
    TA2 8HH Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Redcot Kingston St Mary
    TA2 8HH Taunton
    Somerset
    British19448620001
    SUTHERLAND, Alan George
    c/o Marine Harvest Scotland
    Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    1st Floor
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    c/o Marine Harvest Scotland
    Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    1st Floor
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritish121052220002
    WARRINGTON, Mark Kenneth
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Phoenix House
    North Lanarkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Phoenix House
    North Lanarkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish163601720001
    YOUNG, William
    Argyll Road
    Kirn
    PA23 8EJ Dunoon
    95
    Argyll
    United Kingdom
    Administrateur
    Argyll Road
    Kirn
    PA23 8EJ Dunoon
    95
    Argyll
    United Kingdom
    United KingdomBritish137835400001
    DURANO LIMITED
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Administrateur désigné
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    900003320001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MERIDIAN SALMON FARMS (ARGYLL) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Dnb Bank Asa
    Dronning Eufemias
    0191 Oslo
    Gate 30
    Norway
    04 juil. 2017
    Dronning Eufemias
    0191 Oslo
    Gate 30
    Norway
    Non
    Forme juridiqueCorporation Listed On Oslo Stock Exchange
    Pays d'enregistrementNorway
    Autorité légaleNorweigian
    Lieu d'enregistrementNorway
    Numéro d'enregistrement984 851 006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Den Norske Nominees Limited
    Walbrook Building
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    8th Floor
    England
    04 juil. 2017
    Walbrook Building
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    8th Floor
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House, England And Wales
    Numéro d'enregistrement01012921
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Scotland
    06 avr. 2016
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Acts
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc390172
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    MERIDIAN SALMON FARMS (ARGYLL) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 juil. 2017
    Livré le 11 juil. 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Bank Asa
    Transactions
    • 11 juil. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 déc. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 01 févr. 2011
    Livré le 08 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 08 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage of a ship
    Créé le 15 févr. 2010
    Livré le 20 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the vessel names sarah-ann, official number 916265.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 09 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenants
    Créé le 26 janv. 2010
    Livré le 12 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The vessel the earnings and all requisition compensation.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 12 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 09 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of amendment and confirmation to the share pledge
    Créé le 19 sept. 2008
    Livré le 07 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The existing shares and any other assets.
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 07 oct. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of amendment to the floating charge
    Créé le 19 sept. 2008
    Livré le 07 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 07 oct. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Deed of amendment to the standard security
    Créé le 19 sept. 2008
    Livré le 07 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Barn and land of craigenterve (otherwise carnassary mill), kilmartin, argyll.
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 07 oct. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 08 janv. 2008
    Livré le 15 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Barn and land of craigenterve (otherwise carnassary mill), kilmartin, argyll.
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 15 janv. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Share pledge
    Créé le 13 déc. 2007
    Livré le 24 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The company pledges and assigns to the security agent the existing shares and any other assets to which it is entitled at the date of this share pledge and the company undertakes to pledge and assign to the security agent any assets to which it becomes entitled after the date of the share pledge.
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 24 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 12 déc. 2007
    Livré le 24 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 24 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 oct. 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 29 août 2000
    Livré le 01 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Carnassary mill, kilmartin, argyll.
    Personnes ayant droit
    • Den Norske Bank Asa
    Transactions
    • 01 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 29 août 2000
    Livré le 01 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease granted by fiona gray-stephens over subjects in kilmartin, argyll.
    Personnes ayant droit
    • Den Norske Bank Asa
    Transactions
    • 01 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 05 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Den Norske Bank Asa
    Transactions
    • 05 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 mars 1997
    Livré le 04 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Barn and land of craigentenve (otherwise carnassary mill) (otherwise carnasserie mill) lying in the parish of kilmarnock and county of argyll.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 07 févr. 1996
    Livré le 28 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 05 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Semi submersible feeding module supplied to lakeland marine farm limited by feeding systems a/s pursuant to a contract dated 29 november 1994.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Feeding Systems a/S
    Transactions
    • 05 juin 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 mars 1993
    Livré le 06 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bleaklow Mining Company Limited
    Transactions
    • 06 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0