BONDAREA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBONDAREA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC137651
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BONDAREA LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BONDAREA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ten
    George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BONDAREA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour BONDAREA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    9 pages4.26(Scot)

    Deuxième dépôt pour la nomination de Christopher Heath en tant qu'administrateur

    6 pagesRP04AP01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 4 Cadogan Square Cadogan Street Glasgow G2 7PH

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 4 Cadogan Square Cadogan Street Glasgow G2 7PH

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 4 Cadogan Square Cadogan Street Glasgow G2 7PH à Ten George Street Edinburgh EH2 2DZ le 26 sept. 2016

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 sept. 2016

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juin 2016

    État du capital au 28 juin 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Mr Christopher Heath en tant qu'administrateur le 15 mars 2016

    2 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    26 janv. 2017Second Filing The information on the form AP01 has been replaced by a second filing on 26/01/2017

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    8 pagesAA

    État du capital au 02 juil. 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Company reduce nominal value of each issued share from £1 to £0.00002 19/06/2015
    RES13

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 juin 2015

    État du capital au 04 juin 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Nomination de Mr James Owen Percival en tant qu'administrateur le 11 mars 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Hilton Corporate Director Llc en tant que directeur le 11 mars 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Brian Wilson en tant que directeur le 11 mars 2015

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    6 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Mark Jonathan Way en tant que directeur le 29 août 2014

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    8 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BONDAREA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HLT SECRETARY LIMITED
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6397987
    125128960001
    BEASLEY, Stuart
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish188237620001
    HEATH, Christopher Philip
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    United Kingdom
    Administrateur
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    United Kingdom
    EnglandBritish205835660001
    PERCIVAL, James Owen
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish161274380001
    AIKEN, Peter David
    Westwood Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    Secrétaire
    Westwood Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    British1335570001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Secrétaire
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    VARMA, Rupinder
    65 Broad Walk
    Heston
    TW5 9AA Hounslow
    Middlesex
    Secrétaire
    65 Broad Walk
    Heston
    TW5 9AA Hounslow
    Middlesex
    British27504050001
    WILSON, Brian
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    Secrétaire
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    British125151140001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    MENZIES DOUGAL WS
    12 Bruntsfield Crescent
    EH10 4HA Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    12 Bruntsfield Crescent
    EH10 4HA Edinburgh
    Midlothian
    412160001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    East Barn
    Glory Hill Farm
    HP9 1XE Beaconsfield
    Bucks
    Administrateur
    East Barn
    Glory Hill Farm
    HP9 1XE Beaconsfield
    Bucks
    British111188430001
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Administrateur
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    GIBSON, Dale
    57 Buckstone Hill
    EH10 6TL Edinburgh
    Administrateur
    57 Buckstone Hill
    EH10 6TL Edinburgh
    British42880870001
    HUMPHREYS, Stephen
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    Administrateur
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    British71438830004
    JAMES, Paul Frederick
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    Administrateur
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    British48791500001
    LICHMAN, Laurence
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    Administrateur
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    British143730380001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    RABIN, Elizabeth Jane
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    Administrateur
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    EnglandBritish125139540001
    THOMSON, Jonathan David
    79 Hamlet Gardens
    Hammersmith
    W6 0SX London
    Administrateur
    79 Hamlet Gardens
    Hammersmith
    W6 0SX London
    British117323980001
    VARMA, Navin Kumar
    Eton House
    10 The Chase
    SL5 7UJ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Eton House
    10 The Chase
    SL5 7UJ Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish,104860560001
    VARMA, Rupinder
    65 Broad Walk
    Heston
    TW5 9AA Hounslow
    Middlesex
    Administrateur
    65 Broad Walk
    Heston
    TW5 9AA Hounslow
    Middlesex
    British27504050001
    WAY, Mark Jonathan
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    Administrateur
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    United KingdomBritish191239860001
    WILSON, Brian
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    Administrateur
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    United KingdomBritish125151140001
    HILTON CORPORATE DIRECTOR LLC
    2711 Centerville Road
    19808 Wilmington
    Corporation Service Company
    Delaware
    United States
    Administrateur
    2711 Centerville Road
    19808 Wilmington
    Corporation Service Company
    Delaware
    United States
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY COMPANY
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleDELAWARE USA
    Numéro d'enregistrement4610978
    134765240001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001
    LADBROKE CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    62360460001

    BONDAREA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An assignment of affiliate management agreement
    Créé le 25 juin 2008
    Livré le 16 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All the real estate borrower's right right title and interest in and to the management agreement.
    Personnes ayant droit
    • Bear Stearns Commercial Mortgage, Inc. and Others
    Transactions
    • 16 juil. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A collateral assignment of interest rate cap agreement
    Créé le 25 juin 2008
    Livré le 16 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All of its interest in to and under confirmations.
    Personnes ayant droit
    • Bear Stearns Commercial Mortgage, Inc. and Others
    Transactions
    • 16 juil. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Collateral assignment of currency agreement
    Créé le 25 juin 2008
    Livré le 16 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All right title and interest to receive income revenues and other payments due from the counterparty. See form 410 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Bear Stearns Commercial Mortgage, Inc. and Others
    Transactions
    • 16 juil. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Collateral assignment of interest rate protection agreement
    Créé le 25 juin 2008
    Livré le 16 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All the assignors right title and interest to receive income, revenues and other payments due from the counterparty. See form for further details.
    Personnes ayant droit
    • Bear Stearns Commercial Mortgage, Inc. and Others
    Transactions
    • 16 juil. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 01 nov. 2007
    Livré le 13 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects known as the grosvenor club at 18,20,22 and 24 grosvenor street and 12 lansdowne crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Bear, Stearns International Limited
    Transactions
    • 13 nov. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 24 oct. 2007
    Livré le 14 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bear, Stearns International Limited
    Transactions
    • 14 nov. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 24 oct. 2007
    Livré le 13 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage, fixed charges and floating charge over all assets - see form 410 for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bear, Stearns International Limited
    Transactions
    • 13 nov. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 07 déc. 1992
    Livré le 17 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The clarendon hotel, 18/24 grosvenor street and 12 lansdowne crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 déc. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 19 oct. 1992
    Livré le 22 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 oct. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    BONDAREA LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 sept. 2016Commencement of winding up
    10 oct. 2017Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0