MDP HOTEL & LEISURE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMDP HOTEL & LEISURE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC138202
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MDP HOTEL & LEISURE LIMITED ?

    • Activités de conseil en gestion autres que la gestion financière (70229) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MDP HOTEL & LEISURE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    64 Allardice Street
    AB39 2AA Stonehaven
    Kincardineshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MDP HOTEL & LEISURE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MERCURY MANAGEMENT (SCOTLAND) LIMITED09 nov. 199409 nov. 1994
    MDP HOTEL & LEISURE LIMITED11 mai 199211 mai 1992

    Quels sont les derniers comptes de MDP HOTEL & LEISURE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MDP HOTEL & LEISURE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MDP HOTEL & LEISURE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juin 2015

    État du capital au 24 juin 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014

    7 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mai 2014

    État du capital au 16 mai 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 11 Allardice Street Stonehaven Aberdeenshire AB39 2BS* le 22 juin 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Frances Allan le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Paul Devall le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2007

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de MDP HOTEL & LEISURE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DEVALL, Frances
    The Town House
    7 Cathedral Square
    IV10 8TB Fortrose
    Ross Shire
    Secrétaire
    The Town House
    7 Cathedral Square
    IV10 8TB Fortrose
    Ross Shire
    British99429900002
    DEVALL, Christopher Paul
    The Town House
    7 Cathedral Square
    IV10 8TB Fortrose
    Ross Shire
    Administrateur
    The Town House
    7 Cathedral Square
    IV10 8TB Fortrose
    Ross Shire
    United KingdomBritish84083180002
    MARSHALL, Anthony Derek
    Inglenook
    18 Chartwell Grove,Mapperley Plains
    NG3 5RD Nottingham
    Secrétaire
    Inglenook
    18 Chartwell Grove,Mapperley Plains
    NG3 5RD Nottingham
    British5277910002
    MITCHELL, Paul Anthony
    42 Preston Crescent
    KY11 1DS Inverkeithing
    Fife
    Secrétaire
    42 Preston Crescent
    KY11 1DS Inverkeithing
    Fife
    British61652310002
    PORTER, Hugh Leslie
    Hawthorn House
    Badger Road, Beckbury
    TF11 9DQ Shifnal
    Salop
    Secrétaire
    Hawthorn House
    Badger Road, Beckbury
    TF11 9DQ Shifnal
    Salop
    British63443690001
    SANDERS, Anthony Raymond
    Foxwood
    Kington Rise Kington Lane
    CV35 8PN Claverdon
    Warwickshire
    Secrétaire
    Foxwood
    Kington Rise Kington Lane
    CV35 8PN Claverdon
    Warwickshire
    British44653470002
    SANDERS, Anthony Raymond
    Little Paddocks
    Danzey Green
    B94 5BB Tanworth In Arden
    Warwickshire
    Secrétaire
    Little Paddocks
    Danzey Green
    B94 5BB Tanworth In Arden
    Warwickshire
    British44653470001
    THORNTON, Kevin
    10 Park View Road
    B74 4PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    10 Park View Road
    B74 4PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British44110490001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    SMALLS CHARTERED ACCOUNTANTS
    Ratho Hall Baird Road
    Ratho
    EH28 8QY Newbridge
    Midlothian
    Secrétaire
    Ratho Hall Baird Road
    Ratho
    EH28 8QY Newbridge
    Midlothian
    6634070005
    BAKER, Arthur Sidney
    Tanglewood
    25 Chantry Road Stourton
    DY7 6SA Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    Tanglewood
    25 Chantry Road Stourton
    DY7 6SA Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish37624890002
    BOURTON, Richard
    Gold Acre
    Burton Road Elford
    B79 9BN Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    Gold Acre
    Burton Road Elford
    B79 9BN Tamworth
    Staffordshire
    United KingdomBritish37624870001
    DUNCAN, Nigel Rodney
    7 Denham Green Terrace
    EH5 3PG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    7 Denham Green Terrace
    EH5 3PG Edinburgh
    Midlothian
    British56367950001
    FINDLAY, Ralph Graham
    3 Wells Close
    WV16 5JQ Bridgnorth
    Shropshire
    Administrateur
    3 Wells Close
    WV16 5JQ Bridgnorth
    Shropshire
    British47635420001
    MARSHALL, Anthony Derek
    Inglenook
    18 Chartwell Grove,Mapperley Plains
    NG3 5RD Nottingham
    Administrateur
    Inglenook
    18 Chartwell Grove,Mapperley Plains
    NG3 5RD Nottingham
    British5277910002
    MITCHELL, Paul Anthony
    42 Preston Crescent
    KY11 1DS Inverkeithing
    Fife
    Administrateur
    42 Preston Crescent
    KY11 1DS Inverkeithing
    Fife
    British61652310002
    SANDERS, Anthony Raymond
    Foxwood
    Kington Rise Kington Lane
    CV35 8PN Claverdon
    Warwickshire
    Administrateur
    Foxwood
    Kington Rise Kington Lane
    CV35 8PN Claverdon
    Warwickshire
    British44653470002
    SMALL, Fredrick
    Ratho Hall
    Baird Road
    EH28 8QY Ratho
    Administrateur
    Ratho Hall
    Baird Road
    EH28 8QY Ratho
    British851290003
    SMALL, Janet Margaret
    Ballochruin Farm
    G63 0LE Balfron Station
    Administrateur
    Ballochruin Farm
    G63 0LE Balfron Station
    ScotlandBritish95171940001
    THORNTON, Kevin
    10 Park View Road
    B74 4PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    10 Park View Road
    B74 4PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishBritish44110490001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    MDP HOTEL & LEISURE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 26 avr. 1996
    Livré le 02 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 02 mai 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 déc. 1995
    Livré le 15 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The duddingston mull inn, 189 duddingston park south, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee
    Transactions
    • 15 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 déc. 1995
    Livré le 15 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Brennan's bar, 36 st john street, perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee
    Transactions
    • 15 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 30 nov. 1995
    Livré le 05 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 05 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 août 1994
    Livré le 15 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All and whole ground extending to five hundred and seven decimal or one thousandth parts of an acre or thereby,formerly part of the estate of nidrrie marischal,edinburgh and now known as the duddingston mull inn, 189 duddingston park south,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 25 sept. 1993
    Livré le 07 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 20 août 1992
    Livré le 02 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 sept. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0