HOGANESS SALMON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHOGANESS SALMON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC138818
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HOGANESS SALMON LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HOGANESS SALMON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o MARINE HARVEST SCOTLAND
    1st Floor Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    Fife
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HOGANESS SALMON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HOGANESS SALMON LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HOGANESS SALMON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juil. 2015

    État du capital au 06 juil. 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 juil. 2014

    État du capital au 04 juil. 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * Ratho Park 88 Glasgow Road Ratho Station Newbridge Midlothian EH28 8PP Scotland* le 30 juin 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Paul Irving en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Lorraine Thompson en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Alan George Sutherland en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de William Young en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Colin Blair en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Kenneth James Mcintosh en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de * Johnstone House 52-54 Rose Street Aberdeen AB10 1HA* le 04 mars 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Ledingham Chalmers Llp en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Mark Warrington en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Barrie Irving en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr William Young en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HOGANESS SALMON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THOMPSON, Lorraine
    c/o Marine Harvest Scotland
    Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    1st Floor
    Fife
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Marine Harvest Scotland
    Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    1st Floor
    Fife
    Scotland
    185622130001
    MCINTOSH, Kenneth James
    c/o Marine Harvest Scotland
    Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    1st Floor
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    c/o Marine Harvest Scotland
    Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    1st Floor
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritish124854160002
    SUTHERLAND, Alan George
    c/o Marine Harvest Scotland
    Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    1st Floor
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    c/o Marine Harvest Scotland
    Admiralty Park
    Admiralty Road
    KY11 2YW Rosyth
    1st Floor
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritish121052220002
    ROBERTSON, Maisie Nell
    Hoganess
    Bridge Of Walls
    ZE2 9NR Shetland
    Secrétaire
    Hoganess
    Bridge Of Walls
    ZE2 9NR Shetland
    British45678990001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    112938080001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    NOMINEE SECRETARIES LTD
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    Secrétaire désigné
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    900006780001
    BAKKE, Haavard
    N-5464
    Dimmelsvik
    Norway
    Administrateur
    N-5464
    Dimmelsvik
    Norway
    Norwegian84916280001
    BLAIR, Colin Ian
    9 Fernoch Crescent
    PA31 8AE Lochgilphead
    Argyll
    Administrateur
    9 Fernoch Crescent
    PA31 8AE Lochgilphead
    Argyll
    United KingdomScottish83104090001
    IRVING, Paul Barrie
    Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Little Oak
    Cumbria
    United Kingdom
    Administrateur
    Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Little Oak
    Cumbria
    United Kingdom
    United KingdomBritish24916240001
    IRVING, Paul Barrie
    Little Oak,Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    Little Oak,Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish24916240001
    LISTON, William Munro
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Administrateur
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    United KingdomBritish58492580002
    ROBERTSON, Maisie Nell
    Hoganess
    Bridge Of Walls
    ZE2 9NR Shetland
    Administrateur
    Hoganess
    Bridge Of Walls
    ZE2 9NR Shetland
    British45678990001
    ROBERTSON, Malcolm George
    Hoganess
    Bridge Of Walls
    ZE2 9NR Shetland
    Administrateur
    Hoganess
    Bridge Of Walls
    ZE2 9NR Shetland
    British45678900001
    WARRINGTON, Mark Kenneth
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Phoenix House
    North Lanarkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Phoenix House
    North Lanarkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish163601720001
    YOUNG, William
    Argyll Road
    Kirn
    PA23 8EJ Dunoon
    95
    Argyll
    United Kingdom
    Administrateur
    Argyll Road
    Kirn
    PA23 8EJ Dunoon
    95
    Argyll
    United Kingdom
    United KingdomBritish137835400001
    NOMINEE DIRECTORS LIMITED
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    Administrateur
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    32142300001

    HOGANESS SALMON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 01 févr. 2011
    Livré le 08 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 08 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 16 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of amendment and confirmation to the share pledge
    Créé le 19 sept. 2008
    Livré le 07 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due all sums due or to become due
    Brèves mentions
    The existing shares and any other assets.
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 07 oct. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of amendment to the floating charge
    Créé le 19 sept. 2008
    Livré le 07 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 07 oct. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Share pledge
    Créé le 13 déc. 2007
    Livré le 24 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The company pledges and assigns to the security agent the existing shares and any other assets to which it is entitled at the date of this share pledge and the company undertakes to pledge and assign to the security agent any assets to which it becomes entitled after the date of the share pledge.
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 24 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 12 déc. 2007
    Livré le 24 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 24 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 oct. 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 25 nov. 2004
    Livré le 02 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transactions
    • 02 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 déc. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 16 oct. 2000
    Livré le 23 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Shetland Development Trust
    Transactions
    • 23 oct. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 déc. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 juin 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 15 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 16 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 10 juin 1997
    Livré le 16 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Shetland Leasing and Property Developments Limited
    Transactions
    • 16 juin 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 déc. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 juin 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 09 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 09 déc. 1994
    Livré le 22 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 déc. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 28 avr. 1994
    Livré le 10 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Magnus Laurence Flaws and Others as Trustees of Shetland Aquaculture Trust
    Transactions
    • 10 mai 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 oct. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 déc. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 juin 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 15 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 25 mai 1993
    Livré le 27 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Magnus Laurence Flaws & Others as Trustee of Shetland Aquaculture Trust
    Transactions
    • 27 mai 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 19 avr. 1993
    Livré le 23 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 juin 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 14 janv. 1993
    Livré le 01 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Shetland Islands Councilas Trustee of the High Risk/Unsecured Loan Scheme
    Transactions
    • 01 févr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 14 janv. 1993
    Livré le 01 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Shetland Islands Councilas Trustee of the High Risk/Unsecured Loan Scheme
    Transactions
    • 01 févr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0