WESLO HOUSING MANAGEMENT

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWESLO HOUSING MANAGEMENT
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société SC140597
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WESLO HOUSING MANAGEMENT ?

    • Gestion de la propriété résidentielle (98000) / Activités des ménages employeurs ; activités de production de biens et services non différenciées des ménages pour usage propre

    Où se situe WESLO HOUSING MANAGEMENT ?

    Adresse du siège social
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WESLO HOUSING MANAGEMENT ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le28 févr. 2021
    Date d'échéance des prochains comptes30 nov. 2021
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour WESLO HOUSING MANAGEMENT ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Form b convert to registered society
    1 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to registered society 02/12/2020
    RES13

    Cessation de la nomination de Lynsey Sarah Breen en tant que directeur le 24 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Margaret Stewart Mcintyre en tant qu'administrateur le 28 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Miss Caroline Joanna Dunn Kennedy en tant qu'administrateur le 28 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 29 févr. 2020

    37 pagesAA

    Cessation de la nomination de Kenneth William Mackenzie Tudhope en tant que directeur le 30 juin 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Alistair James Booth en tant qu'administrateur le 27 mai 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Lynsey Sarah Breen en tant qu'administrateur le 27 mai 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Diana Helen Maclean en tant que directeur le 27 mai 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kenneth Redmond en tant que directeur le 27 mai 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Eileen Porter en tant qu'administrateur le 25 mars 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Matthew Torrance en tant que directeur le 10 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Joyce Cameron en tant que directeur le 06 mars 2020

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Diana Helen Maclean le 21 janv. 2020

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Lorraine Paterson en tant que directeur le 15 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Andrew Bruce en tant que directeur le 13 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Douglas William Drummond en tant que directeur le 31 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Kenneth William Mackenzie Tudhope en tant qu'administrateur le 01 août 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Lorraine Paterson en tant qu'administrateur le 17 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 28 févr. 2019

    37 pagesAA

    Nomination de Mr Kenneth Redmond en tant qu'administrateur le 17 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Joyce Cameron en tant qu'administrateur le 17 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de WESLO HOUSING MANAGEMENT ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    T C YOUNG LLP
    West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House, 7
    Scotland
    Secrétaire
    West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House, 7
    Scotland
    92309420002
    BOOTH, Alistair James
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandScottish152845230001
    CASKIE, Donald Ian
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandBritish259479260001
    DEWAR, Katherine Margaret
    North Bridge Street
    EH48 4PP Bathgate
    66
    West Lothian
    Administrateur
    North Bridge Street
    EH48 4PP Bathgate
    66
    West Lothian
    ScotlandBritish141834740001
    FINNIE, George
    High Street
    PA12 4AB Lochwinnoch
    29
    Scotland
    Administrateur
    High Street
    PA12 4AB Lochwinnoch
    29
    Scotland
    ScotlandBritish240422640001
    GREEN, James
    Chestnut Grove
    Stenhousemuir
    FK5 4DU Larbert
    51
    Scotland
    Administrateur
    Chestnut Grove
    Stenhousemuir
    FK5 4DU Larbert
    51
    Scotland
    United KingdomBritish240423000001
    HIGGINS, Brenda
    North Bridge Street
    EH48 4PP Bathgate
    66
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    North Bridge Street
    EH48 4PP Bathgate
    66
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish175534450001
    KENNEDY, Caroline Joanna Dunn
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandBritish259191300001
    MCINTYRE, Margaret Stewart
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandBritish137697520001
    PORTER, Eileen
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandBritish124710570002
    ADDLESHAW GODDARD (SCOTLAND) SECRETARIAL LIMITED
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    Secrétaire
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC131085
    665080009
    HENDERSON BOYD JACKSON LIMITED
    19 Ainslie Place
    EH3 6AU Edinburgh
    Secrétaire désigné
    19 Ainslie Place
    EH3 6AU Edinburgh
    900006190001
    HENDERSON BOYD JACKSON W.S.
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    38350020002
    ANDERSON, Frank, Councillor
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandBritish32218490001
    BALFOUR, Andrew
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandScottish114443900001
    BALFOUR, Andrew
    8 Alexander Drive
    Dedridge
    EH54 6DB Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    8 Alexander Drive
    Dedridge
    EH54 6DB Livingston
    West Lothian
    ScotlandScottish114443900001
    BOW, Alex
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandBritish137697330002
    BREEN, Lynsey Sarah
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandBritish261855190001
    BROWN, Lorna
    71 Parkhead Gardens
    EH55 8BD West Calder
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    71 Parkhead Gardens
    EH55 8BD West Calder
    West Lothian
    Scotland
    British27169470001
    BRUCE, Michael Andrew
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandScottish28068610002
    CAMERON, Joyce
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandScottish260845440001
    CLELAND, Richard
    11 The Avenue
    Whitburn
    EH47 0DD Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    11 The Avenue
    Whitburn
    EH47 0DD Bathgate
    West Lothian
    British64426880001
    CONSTABLE, John
    46 Kinneil Drive
    EH51 0LY Boness
    West Lothian
    Administrateur
    46 Kinneil Drive
    EH51 0LY Boness
    West Lothian
    British65909660001
    CROZIER, Michael Stewart
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandBritish28068620002
    DALTON, Elaine
    17 Staunton Rise
    EH54 6PB Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    17 Staunton Rise
    EH54 6PB Livingston
    West Lothian
    British64426990001
    DALYELL, Kathleen
    The Binns
    EH49 7NA Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    The Binns
    EH49 7NA Linlithgow
    West Lothian
    British39408630001
    DRUMMOND, Douglas William
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandBritish28068590002
    EDWARDS, Carole
    159 Harburn Drive
    EH55 8AW West Calder
    West Lothian
    Administrateur
    159 Harburn Drive
    EH55 8AW West Calder
    West Lothian
    British34366520001
    GOLDIE, Gerald, J.P.
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    Administrateur
    66 North Bridge Street
    Bathgate
    EH48 4PP West Lothian
    ScotlandBritish70302290001
    GRAHAM, Andrew
    55 Pennelton Place
    EH51 0PD Boness
    West Lothian
    Administrateur
    55 Pennelton Place
    EH51 0PD Boness
    West Lothian
    British91670620001
    HARVEY, Patricia Margaret
    12 Forth Street
    FK3 8LE Grangemouth
    Stirlingshire
    Administrateur
    12 Forth Street
    FK3 8LE Grangemouth
    Stirlingshire
    British114443950001
    ILLIDGE, Albert
    21 Liddle Drive
    EH51 0PA Boness
    West Lothian
    Administrateur
    21 Liddle Drive
    EH51 0PA Boness
    West Lothian
    British71489660001
    JACKSON, Alice Ann
    North Bridge Street
    EH48 4PP Bathgate
    66
    West Lothian
    Administrateur
    North Bridge Street
    EH48 4PP Bathgate
    66
    West Lothian
    ScotlandBritish56970002
    JOHNSTONE, Evelyn Dobie
    16 Glen Crescent
    Deans
    EH54 8BW Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    16 Glen Crescent
    Deans
    EH54 8BW Livingston
    West Lothian
    ScotlandBritish71489590001
    LEE, Robert
    157 Lanrigg Road
    Fauldhouse
    EH47 9JJ Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    157 Lanrigg Road
    Fauldhouse
    EH47 9JJ Bathgate
    West Lothian
    British36585760001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour WESLO HOUSING MANAGEMENT ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    08 oct. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    WESLO HOUSING MANAGEMENT a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 déc. 2018
    Livré le 06 déc. 2018
    En cours
    Brève description
    All and whole the subjects registered under the following title numbers:. (1) WLN1259, (2) WLN1268, (3) WLN39001, and (4) WLN47445.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 27 nov. 2017
    Livré le 28 nov. 2017
    En cours
    Brève description
    All and whole the dwellinghouse known as 91 whiteside court, bathgate, EH48 2TP registered in the land register of scotland under title number WLN47447.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, the "Bank" as Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01
    Transactions
    • 28 nov. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 25 mars 2015
    Livré le 02 avr. 2015
    En cours
    Brève description
    Subjects situated at 5 union road, whitburn EH47 0AW (title number WLN3685) and others.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 02 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 25 mars 2015
    Livré le 02 avr. 2015
    En cours
    Brève description
    Subjects situated at bathville court, armadale (title number WLN22645) and others.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 02 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 mars 2015
    Livré le 02 avr. 2015
    En cours
    Brève description
    Subjects situated at mansefield, east calder and others.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 02 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 oct. 2013
    Livré le 30 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    8, yule terrace, blackburn, EH47 7HJ, title number WLN45839;. 51, vale of bonnyview, falkirk, FK4 1BN, title number STG47141;. 90, benhar road, shotts, ML7 5EP, title number LAN153954;. 2, elm square, whitburn, EH47 8NE, title number WLN40839;. 3, yule terrace, blackburn, EH47 7HJ, title number WLN10740;. 66, bankton drive, livingston, EH54 9EJ, title number MID89717;. 25, burns place, shotts, ML7 4LQ, title number LAN132180;. 9, fendoch road, falkirk, FK3 9HB, title number STG7875;. 141, cloglands, forth, ML11 8EH, title number LAN193900;. 13, northfield avenue, shotts, ML7 5HR, title number LAN177326;. 33, avondale drive, armadale, EH48 3HH, title number WLN23452;. 64, carradale avenue, falkirk, FK1 4AF, title number STG4106;. 11, rowan drive, bonnybridge, FK4 1TB, title number STG32605;. 38, carledubs crescent, uphall, EH52 6TQ, title number WLN19126;. 8, tarbert place, carluke, WL8 4JH, title number LAN133658;. 40, woodlands avenue, carluke, ML8 5JL, title number LAN57187;. 15, mansefield, east calder, EH53 0JB, title number MID143354;. 51, dochart crescent, falkirk, FK2 0RE, title number STG67280;. 28, murdostoun crescent, harthill, ML7 5SR, title number LAN129352;. 19, crossgreen place, uphall, EH52 6TD, title number WLN40693;. 63, polmont park, falkirk, FK2 0XU, title number STG58212;. 16, beech crescent, denny, FK6 6LJ, title number STG54095;. 140, lea rig, forth, ML11 8EQ, title number LAN185223;. 23, culmore place, hallglen, FK1 2PP, title number STG56234;. 14, roxburgh place, stenhousemuir, FK5 4UE, title number STG5942;. 98, gardner crescent, whitburn, EH47 0NR, title number WLN4062;. 70, liddle drive, bo'ness, EH51 0PB, title number WLN1591;. 9B, bank street, falkirk, FK1 1NB, title number STG29590;. 4, sunnyside, stoneyburn, EH47 8BZ, title number WLN7291;. 4, gowan avenue, falkirk, FK2 7HL, title number STG33841;. 19, watling drive, falkirk, FK1 4QD, title number STG4761;. 10, paul drive, falkirk, FK2 8LA, title number STG65123;. 128, south street, armadale, EH48 3JU, title number WLN7560;. 58, ladeside road, blackburn, EH47 7JR, title number WLN15586;. 19, greig crescent, armadale, EH48 2PS, title number WLN7147;. 46, cultrig drive, whitburn, EH47 8HP, title number WLN17901;. 7, cardross road, broxburn, EH52 6HU, title number WLN2098;. 14, baillie street, whitburn, EH47 0ER, title number WLN15608;. 62, riverside, newbridge, EH28 8SU, title number MID55827;. 11, dick gardens, whitburn, EH47 0BN, title number WLN35735;. 174, campsrigg, livingston, EH54 8PF, title number WLN10721;. 34, fells rigg, livingston, EH54 8PA, title number WLN18036;. 41, kennard street, falkirk, FK2 9EH, title number STG33791;. 9, cadzow avenue, bo'ness, EH51 9BS, title number WLN10878;. 21, curran crescent, broxburn, EH52 5RY, title number WLN20226;. 18, blaeberryhill road, whitburn, EH47 8LB, title number WLN20831;. 31, ellismuir street, coatbridge, ML5 5BH, title number LAN132819;. 109, park view, fauldhouse, EH47 9LD, title number WLN25917;. 123, barclay way, livingston, EH54 8HA, title number WLN14260;. 6, lenzie avenue, livingston, EH54 8NP, title number WLN15555;. 109, philip avenue, bathgate, EH48 1LZ, title number WLN7666;. 8, union court, bo'ness, EH51 9AJ, title number WLN31759;. 51, fallas place, fauldhouse, EH47 9BZ, title number WLN1702;. 167, muirhall terrace, shotts, ML7 4LX, title number LAN135666;. 32, kirkbrae, longridge, EH47 8AH, title number LN13040;. 84, glenalmond, whitburn, EH47 8NS, title number WLN7037;. 129, overton crescent, denny, FK6 5BA, title number STG2203;. 44, dalderse avenue, falkirk, FK2 7EG, title number STG8007;. 43, townhead gardens, whitburn, EH47 8JL, title number WLN16347; and. 4, union road, whitburn, EH47 0AW, title number WLN11117.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 oct. 2013
    Livré le 30 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    The following subjects recorded in the register of sasines and described in the schedule (as defined in the instrument evidencing the charge accompanying this form MR01);. 43 sedgebank, livinsgton, EH54 6HE, midlothian;. 90 sedgebank, livingston, EH54 6HD, midlothian;. 45 falconer rise, livingston, EH54 6JE, midlothian;. 23 nigel rise, livingston, EH54 6LT, midlothian;. 47 norman rise, livingston, EH54 6LY, midlothian; and. 61 everard rise, livingston, EH54 6JD, midlothian.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 oct. 2013
    Livré le 30 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    All and whole the subjects known as 1-13 (inclusive) and 15 academy view whitburn lying on the northeast side of ellen street, whitburn registered in the land register of scotland under title number WLN39780.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 oct. 2013
    Livré le 30 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    All and whole the subjects known as 1-14 (inclusive) edward avenue, bathgate erected on the area of ground extending to 4458 square metres at charles crescent boghall, bathgate registered in the land register of scotland under title number WLN39779.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 oct. 2013
    Livré le 30 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    All and whole that area or piece of ground at mooreland gardens, addiewell, west calder with the dwellinghouses erected thereon being (one) that area of ground extending to seventy nine decimal or one hundredth parts of an acre or thereby imperial standard measure lying in the parish of west calder and county of midlothian (formerly edinburgh) described in, disponed by and delineated and shown coloured pink on the plan annexed and signed as relative to disposition by the county council of the county of midlothian in favour of scottish special housing association dated seventh and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of midlothian (formerly edinburgh) on sixteenth both days of july nineteen hundred and forty eight; and (two) that area of ground extending to ninety eight decimal or one hundredth parts of an acre or thereby imperial standard measure lying in the said parish and county described in, disponed by and delineated and shown coloured pink on the plan annexed and signed as relative to disposition by david dick tod and another in favour of scottish special housing association dated sixteenth and recorded in the said division of the general register of sasines on twenty sixth both days of july nineteen hundred and forty eight under exception of (first) all and whole the subjects known as and forming 49 mooreland gardens, aforesaid being the subjects more particularly described in and disponed by feu disposition by scottish homes in favour of james toner and rita mary toner dated 28 november 1991 and recorded in the said division of the general register of sasines on 22 may 1992; (second) all and whole the subjects known as 62 mooreland gardens, aforesaid being the subjects more particularly described in and disponed by feu disposition by scottish homes in favour of nora duffy and theresa anne duffy dated 23 september 1993 and recorded in the said division of the general register of sasines on 4 october 1993; (third) all and whole the subjects known as 58 mooreland gardens, aforesaid being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID57927; (fourth) all and whole the subjects known as 47 mooreland gardens aforesaid registered under title number MID119231; and (fifth) all and whole the subjects known as 60 mooreland gardens, aforesaid being the subjects registered in the land register under title number MID126074.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Standard security
    Créé le 05 déc. 2012
    Livré le 24 déc. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects situated at 1,2,3,5,6,7,8,9,12 sheephousehill lane, fauldhouse.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 05 déc. 2012
    Livré le 24 déc. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects situated at 67 howletnest road, airdrie.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2012
    Livré le 24 déc. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects situated at 24 limebank park, east calder.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2012
    Livré le 24 déc. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects situated at 3,6,9,11,14,16,18,19 and 20 cunnigar gardens, midcalder.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2011
    Livré le 28 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 96 gardner crescent, whitburn, title number WLN25694.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 28 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2011
    Livré le 28 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 55 whitelaw drive, title number WLN11326.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 28 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2011
    Livré le 28 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 14 robertson avenue, bathgate, title number WLN4299.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 28 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2011
    Livré le 28 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 87 birkenshaw way, bathgate, title number WLN22199.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 28 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2011
    Livré le 28 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 33 woodend walk, armadale, title number WLN22719.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 28 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2011
    Livré le 28 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 159 woodend walk, armadale, title number WLN26788.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 28 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2011
    Livré le 28 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 27 woodend walk, armadale, title number WLN6154.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 28 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2011
    Livré le 28 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 137 birkenshaw way, bathgate, title number WLN20238.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 28 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2011
    Livré le 28 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 23 loanfoot crescent, broxburn, title number WLN22428.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 28 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2011
    Livré le 28 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 5 kelso street, broxburn, title number WLN19286.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 28 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2011
    Livré le 28 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 122 gardner crescent, whitburn, title number WLN8330.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 28 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0