WOODEND GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWOODEND GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC140935
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WOODEND GROUP LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe WOODEND GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Edinburgh House
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WOODEND GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KINOCARE LIMITED28 oct. 199228 oct. 1992

    Quels sont les derniers comptes de WOODEND GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour WOODEND GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 05 mars 2021

    • Capital: GBP 0.50
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Mrs Janine Butler en tant qu'administrateur le 23 févr. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Nigel Evans en tant que directeur le 23 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 15 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    6 pagesAA

    legacy

    254 pagesPARENT_ACC

    legacy

    2 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Changement d'adresse du siège social de Leven House 10 Lochside Place Edinburgh Park Edinburgh Scotland EH12 9RG à Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ le 15 mai 2019

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Andrew Michael Yorston en tant qu'administrateur le 02 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Diane Josephine Mcintyre en tant que directeur le 16 mars 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 15 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mai 2016

    État du capital au 03 mai 2016

    • Capital: GBP 2,638,257.5
    SH01

    Qui sont les dirigeants de WOODEND GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    75473330004
    BUTLER, Janine
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Administrateur
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    EnglandBritish277534960001
    YORSTON, Andrew Michael
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Administrateur
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    United KingdomBritish257275320001
    BAIRD, Brian Alexander
    4 Cheviot Drive
    G77 5AS Glasgow
    Secrétaire
    4 Cheviot Drive
    G77 5AS Glasgow
    British95529070001
    MACLEOD, David
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    Secrétaire
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    British32696310001
    MCINTYRE, Colin
    473 Clarkston Road
    G44 3LW Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    473 Clarkston Road
    G44 3LW Glasgow
    Lanarkshire
    British732300001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    QUEENSFERRY SECRETARIES LIMITED
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Secrétaire
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    38051430002
    QUILL SERVE LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Secrétaire désigné
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    900000590001
    ALLAN, William
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    Administrateur
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    UkBritish111131550001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    British123612980001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    EVANS, David Nigel
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Administrateur
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    United KingdomBritish134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish158146620001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Administrateur
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HADDOW, Neil Scott
    104 Mearns Road
    Clarkston
    G76 7UP Glasgow
    Administrateur
    104 Mearns Road
    Clarkston
    G76 7UP Glasgow
    British53774190001
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HILLS, Kenneth Cumming
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    British65152940001
    HOULDSWORTH, June
    Baron Hill Nursery 86 Hunthill Road
    High Blantyre
    G72 9UY Glasgow
    Administrateur
    Baron Hill Nursery 86 Hunthill Road
    High Blantyre
    G72 9UY Glasgow
    United KingdomBritish1376720001
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Administrateur
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MATTHEWS, Roderick Alfred
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    British74872510003
    MCALOON, William Gerard
    10 Jacks View
    West Kilbride
    KA23 9HX Ayshire
    Ayrshire
    Administrateur
    10 Jacks View
    West Kilbride
    KA23 9HX Ayshire
    Ayrshire
    British108756350001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish173703620001
    MCLEAN, Gregory Joseph
    3 Princes Terrace
    Dowanhill
    G12 9JW Glasgow
    Administrateur
    3 Princes Terrace
    Dowanhill
    G12 9JW Glasgow
    American33612180002
    NOWAK, Thomas, Dr
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomGerman174443800001
    PRENTICE, Edward Duncan
    72 Lymekilns Road
    East Kilbride
    G74 4TU Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    72 Lymekilns Road
    East Kilbride
    G74 4TU Glasgow
    Lanarkshire
    British72432810001
    PURKESS, Martin John
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritish139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish87149560001
    RUSSELL, Ian Simon Macgregor
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish38783050003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WOODEND GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    06 avr. 2016
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc170238
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WOODEND GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 16 déc. 1992
    Livré le 23 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 déc. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0