INDUSTRIAL AND POWER ASSOCIATION LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INDUSTRIAL AND POWER ASSOCIATION LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | SC140994 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INDUSTRIAL AND POWER ASSOCIATION LIMITED ?
| Adresse du siège social | 4 Old Glasgow Road Stewarton KA3 5JJ Kilmarnock Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INDUSTRIAL AND POWER ASSOCIATION LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INDUSTRIAL AND POWER ASSOCIATION LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 sept. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 23 sept. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 sept. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour INDUSTRIAL AND POWER ASSOCIATION LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2025 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Colin Gordon Mcnaught en tant que secrétaire le 08 sept. 2025 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de David Macdonald Cameron en tant que directeur le 08 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de David Macdonald Cameron en tant que secrétaire le 08 sept. 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024 | 4 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan Russell Hendry le 15 mai 2018 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de David James Irving en tant que directeur le 16 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 4 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 4 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Stuart Noble en tant que directeur le 14 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Nicholas Charles Carlin en tant que directeur le 14 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021 | 4 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020 | 4 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019 | 4 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018 | 4 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de David William Barrie en tant que directeur le 03 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de C/O Fergusons Chartered Accountants 24 Woodside Houston Johnstone Renfrewshire PA6 7DD Scotland à 4 Old Glasgow Road Stewarton Kilmarnock KA3 5JJ le 14 févr. 2019 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de INDUSTRIAL AND POWER ASSOCIATION LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCNAUGHT, Colin Gordon | Secrétaire | Old Glasgow Road Stewarton KA3 5JJ Kilmarnock 4 Scotland | 340026620001 | |||||||
| HENDRY, Alan Russell | Administrateur | Old Glasgow Road Stewarton KA3 5JJ Kilmarnock 4 Scotland | Scotland | British | 107655260002 | |||||
| MCNAUGHT, Colin Gordon | Administrateur | Old Glasgow Road Stewarton KA3 5JJ Kilmarnock 4 Scotland | United Kingdom | British | 123220520001 | |||||
| SPENCE, Grant Craig | Administrateur | Old Glasgow Road Stewarton KA3 5JJ Kilmarnock 4 Scotland | Scotland | British | 184422500001 | |||||
| CAMERON, David Macdonald | Secrétaire | Old Glasgow Road Stewarton KA3 5JJ Kilmarnock 4 Scotland | 176107990001 | |||||||
| DOWDLES, Margaret | Secrétaire | Top Right 127 Novar Drive Hyndland G12 9TA Glasgow Lanarkshire | British | 3479150001 | ||||||
| EDWARDS, Jacqueline | Secrétaire | 8 North Gardner Street G11 5BT Glasgow | British | 35757200001 | ||||||
| LOUDON, Robert | Secrétaire | 81 Hawthorn Avenue Bearsden G61 3NF Glasgow | British | 61524480001 | ||||||
| SHIELDS, Charles Shields | Secrétaire | 11 Low Barholm Kilbarchan PA10 2ES Johnstone Renfrewshire | British | 35832310001 | ||||||
| SHIELDS, Charles Shields | Secrétaire | 11 Low Barholm Kilbarchan PA10 2ES Johnstone Renfrewshire | British | 35832310001 | ||||||
| ARMSTRONG, Hugh Blair | Administrateur | Fir Trees Milndavie Road, Strathblane G63 9EW Glasgow Lanarkshire | British | 63563890001 | ||||||
| BARRIE, David William | Administrateur | Old Glasgow Road Stewarton KA3 5JJ Kilmarnock 4 Scotland | Scotland | British | 212553950001 | |||||
| CAMERON, David Macdonald | Administrateur | Old Glasgow Road Stewarton KA3 5JJ Kilmarnock 4 Scotland | Scotland | British | 150622560003 | |||||
| CARLIN, Nicholas Charles | Administrateur | James Watt Avenue East Kilbride G75 0QD Glasgow Brunel Building South Lanarkshire | Scotland | British | 184623090001 | |||||
| CHERRIE, John Thomson | Administrateur | 9 Brigside Gardens ML3 7BG Hamilton Lanarkshire | Scotland | British | 118721880001 | |||||
| DALY, Robert | Administrateur | 47 Ruthrieston Court Riverside Drive AB10 7QF Aberdeen | British | 1298250001 | ||||||
| DEED, Stuart George Mackie | Administrateur | 6 Torwoodlee PH1 1SY Perth Perthshire | Scotland | British | 119417460001 | |||||
| DUGGAN, Jill Patricia | Administrateur | James Watt Avenue East Kilbride G75 0QD Glasgow Brunel Building South Lanarkshire Scotland | England | British | 170736720001 | |||||
| DUNDAS, Alan Ralph | Administrateur | 32 East Abercrombie Street G84 7SQ Helensburgh | British | 708940001 | ||||||
| DUNWOODY, Robert Kerrigan | Administrateur | Lauderdale Gardens G12 9QW Glasgow 1/1 68 | Scotland | British | 146665630001 | |||||
| FAIRBAIRN, James Bennett | Administrateur | 8 John Murray Drive Bridge Of Allan FK9 4QH Stirling Stirlingshire | United Kingdom | British | 163543080001 | |||||
| FARLEY, John Michael, Dr | Administrateur | James Watt Avenue East Kilbride G75 0QD Glasgow Brunel Building South Lanarkshire | United Kingdom | British | 16408890001 | |||||
| FELLOWS, Andrew | Administrateur | 9d Hughenden Gardens Hyndland G12 9XW Glasgow Lanarkshire | British | 66896820002 | ||||||
| GALLOWAY, Brian | Administrateur | James Watt Avenue East Kilbride G75 0QD Glasgow Brunel Building South Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 165318440001 | |||||
| GIBSON, Thomas | Administrateur | 25 Huntly Gardens G12 9AU Glasgow | United Kingdom | British | 51685950003 | |||||
| HOLMES, Robert | Administrateur | Doonfoot Gardens East Kilbride G74 4XF Glasgow 10 United Kingdom | Scotland | British | 117012030002 | |||||
| HUNTER, Raymond Stephen | Administrateur | 14 Spean Avenue G74 2HY St Leonards Lanarkshire | Scotland | British | 206381740001 | |||||
| IRVING, David James | Administrateur | Old Glasgow Road Stewarton KA3 5JJ Kilmarnock 4 Scotland | Scotland | British | 176062580001 | |||||
| LAUDER, Roy James | Administrateur | 13 Ruthven Street Hillhead G12 9BY Glasgow Lanarkshire Scotland | British | 30186400001 | ||||||
| LEE, Derek William | Administrateur | Higher Hall Edale Road Hope S30 2RF Sheffield South Yorkshire | British | 13823020001 | ||||||
| LOUDON, Robert | Administrateur | 81 Hawthorn Avenue Bearsden G61 3NF Glasgow | British | 61524480001 | ||||||
| MCCABE, Robert Anthony | Administrateur | James Watt Avenue East Kilbride G75 0QD Glasgow Brunel Building South Lanarkshire | Scotland | British | 193905940001 | |||||
| MCHALE, James Bartholomew | Administrateur | Elgar, 3a East Montrose Street G84 7ER Helensburgh Dunbartonshire | British | 59337240001 | ||||||
| MCMILLAN, Fraser James John | Administrateur | Bothwell Street G2 7EQ Glasgow 141 Scotland | Scotland | British | 174942550001 | |||||
| MCWHIRTER, Alexander Fulton | Administrateur | 1 Carlung Place KA23 9JP West Kilbride Ayrshire | British | 38494390001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour INDUSTRIAL AND POWER ASSOCIATION LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 30 oct. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0