ASHBOURNE GROUP UK LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ASHBOURNE GROUP UK LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC141431 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ASHBOURNE GROUP UK LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP 249 West George Street G2 4RB Glasgow United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour ASHBOURNE GROUP UK LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire le 09 oct. 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Avis de la réalisation de l'accord amiable | 6 pages | 1.4(Scot) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy James Bolot en tant que directeur le 17 août 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Avis du rapport de la réunion approuvant l'accord amiable avec les créanciers | 4 pages | 1.1(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor, Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland le 20 janv. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 15 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Andrew Smith en tant que directeur le 01 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Jonathan Taylor en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy James Bolot en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2010 | 30 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Mcleish en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Midmer en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 193 Bath Street Glasgow G2 4HU le 27 juil. 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 27 sept. 2009 | 26 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Andrew Smith le 07 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination d'un administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lynn Fearn en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Administrateur | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| FEENEY, Martin | Secrétaire | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Secrétaire | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Secrétaire | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Secrétaire | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Secrétaire | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secrétaire | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | 158304650001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Secrétaire | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | British | 168970640001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Secrétaire | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Secrétaire | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| BIGGART BAILLIE & GIFFORD WS | Secrétaire désigné | 11 Glenfinlas Street Edinburgh Lothian | 900005750001 | |||||||
| ABLETT, Julie | Administrateur | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BARLOW, George Edward | Administrateur | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Administrateur | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Administrateur | Pipers Cottage Grove Heath Road Ripley GU23 6EU Woking Surrey | American | 51593550001 | ||||||
| BROKE, Michael Haviland Adlington | Administrateur | 7 Westmead Roehampton SW15 5BH London | British | 2996750001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Administrateur | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Administrateur | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| DAVIS, Mary | Administrateur | Oakdene 200 Culduthel Road IV2 4BH Inverness | British | 76212360001 | ||||||
| DENNY, Nigel John | Administrateur | Brook House The Manor Potton SG19 2RN Sandy Bedfordshire | British | 53339290001 | ||||||
| FARRALL, Elaine Ann | Administrateur | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEARN, Lynn | Administrateur | Elmwood Drive DE55 7QJ Alfreton 24 Derbyshire | United Kingdom | British | 130867640001 | |||||
| FEENEY, Martin | Administrateur | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Administrateur | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Administrateur | 193 Bath Street Glasgow G2 4HU | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| FOULKES, Kamma | Administrateur | 17 Lower Castle Street NP7 5EE Abergavenny Monmouthshire | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Administrateur | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| GUEST, Walter Henry | Administrateur | Spindleberry Pine Avenue GU15 2LY Camberley Surrey | British | 4200040001 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Administrateur | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Administrateur | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LAWRENCE, Stephen John | Administrateur | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | 5579020001 | |||||
| LEVICK, Ann | Administrateur | 57a Highlands Heath SW15 3TX London | British | 37880870004 | ||||||
| LOCK, Jason David | Administrateur | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MCINTEER, Warren Hill | Administrateur | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Administrateur | The Castle Business Park, Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling C/O Southern Cross Healthcare Scotland Scotland | England | British | 110640170001 |
ASHBOURNE GROUP UK LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of acquisition agreement | Créé le 01 févr. 1993 Livré le 19 févr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions In the charge of acquisition agreement topco as beneficial owner charges by way of first fixed charge to the security agent as a continuing security fot the secured obligations the full benefit of the acquisition agreement and all thhe right title and interest whatsoever of topco therein (together the "charged property"). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
ASHBOURNE GROUP UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Corporate voluntary arrangement (CVA) |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0