ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC141433 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP 249 West George Street G2 4RB Glasgow United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire le 09 oct. 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy James Bolot en tant que directeur le 31 août 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Charles Lovett en tant qu'administrateur le 31 août 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Avis de la réalisation de l'accord amiable | 6 pages | 1.4(Scot) | ||||||||||
Avis du rapport de la réunion approuvant l'accord amiable avec les créanciers | 4 pages | 1.1(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor, Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland le 20 janv. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 15 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Andrew Smith en tant que directeur le 01 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Jonathan Taylor en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy James Bolot en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2010 | 18 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Mcleish en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Midmer en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 193 Bath Street Glasgow G2 4HU le 28 juil. 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 27 sept. 2009 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Andrew Smith le 07 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination d'un administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVETT, David Charles | Administrateur | The Grange SW19 4PS London 17 England England | United Kingdom | British | 34419700002 | |||||
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Administrateur | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| FEENEY, Martin | Secrétaire | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Secrétaire | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Secrétaire | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Secrétaire | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Secrétaire | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secrétaire | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | 158304690001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Secrétaire | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | British | 168970640001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Secrétaire | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Secrétaire | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Secrétaire | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| BIGGART BAILLIE & GIFFORD WS | Secrétaire désigné | 11 Glenfinlas Street Edinburgh Lothian | 900005750001 | |||||||
| ABLETT, Julie | Administrateur | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BARLOW, George Edward | Administrateur | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Administrateur | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Administrateur | Pipers Cottage Grove Heath Road Ripley GU23 6EU Woking Surrey | American | 51593550001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Administrateur | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Administrateur | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| DAVIS, Mary | Administrateur | Oakdene 200 Culduthel Road IV2 4BH Inverness | British | 76212360001 | ||||||
| DENNY, Nigel John | Administrateur | Brook House The Manor Potton SG19 2RN Sandy Bedfordshire | British | 53339290001 | ||||||
| FARRALL, Elaine Ann | Administrateur | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Administrateur | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Administrateur | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Administrateur | 193 Bath Street Glasgow G2 4HU | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Administrateur | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| GUEST, Walter Henry | Administrateur | Spindleberry Pine Avenue GU15 2LY Camberley Surrey | British | 4200040001 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Administrateur | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Administrateur | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LAWRENCE, Stephen John | Administrateur | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | 5579020001 | |||||
| LOCK, Jason David | Administrateur | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MCINTEER, Warren Hill | Administrateur | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Administrateur | The Castle Business Park, Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling C/O Southern Cross Healthcare Scotland Scotland | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Administrateur | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| PHIPPEN, Kent William | Administrateur | 12 Elm Tree Road St Johns Wood NW8 9JX London | United Kingdom | American | 84576560001 |
ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession and charge | Créé le 21 août 2008 Livré le 03 sept. 2008 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due all sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 02 sept. 1996 Livré le 18 sept. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charges.collingwood grange,portsmouth road,camberley,surrey. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 02 févr. 1995 Acquis le 03 févr. 1995 Livré le 12 avr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due, or to become due | |
Brèves mentions Annfield house, stirling, registered under title number stg 9911. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 19 avr. 1994 Livré le 22 avr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Broomcroft, ecclesall road, south sheffield, south yorkshire.... See ch microfiche. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 09 juin 1993 Livré le 25 juin 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 174 norwich road, ipswich and 176-182 (even nos) norwich road, ipswich. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture | Créé le 01 févr. 1993 Acquis le 01 févr. 1993 Livré le 11 mars 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Broomcroft eccleshall road south sheffield and 12 other properties see paper apart 2. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 01 févr. 1993 Livré le 12 févr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Area of ground at torr road, quarrier's village, bridge of weir registered title number ren 58217 together with the mines, minerals, metals and fossils within and under the said subjects but that only in so far as the company has right thereto, the whole buildings and other erections if any to be erected thereon, the heritable fittings and fixtures therein and thereon and the parts, pertinents and priveleges thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed charge | Créé le 01 févr. 1993 Livré le 04 févr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions A. by way of legal mortgage the mortaged propery as listed in the paper apart, together with all fixed plant and machinery and fixtures thereto. B. by way of specific equitable charge all estates or interests in any freehold or leasehold property (except the mortgaged property and any such property as may be situated in scotland) now or at any time during the subsistence of the charge belonging to or charged to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 01 févr. 1993 Livré le 04 févr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Corporate voluntary arrangement (CVA) |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0