ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED

ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC141433
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DALGLEN (NO. 506) LIMITED25 nov. 199225 nov. 1992

    Quels sont les derniers comptes de ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire le 09 oct. 2012

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Timothy James Bolot en tant que directeur le 31 août 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Charles Lovett en tant qu'administrateur le 31 août 2012

    2 pagesAP01

    Avis de la réalisation de l'accord amiable

    6 pages1.4(Scot)

    Avis du rapport de la réunion approuvant l'accord amiable avec les créanciers

    4 pages1.1(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor, Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland le 20 janv. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 janv. 2012

    État du capital au 18 janv. 2012

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 15 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Andrew Smith en tant que directeur le 01 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Jonathan Taylor en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Timothy James Bolot en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    18 pagesAA

    Nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de William Mcleish en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Richard Midmer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 193 Bath Street Glasgow G2 4HU le 28 juil. 2010

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Enter into various agreements 14/05/2010
    RES13

    Comptes annuels établis au 27 sept. 2009

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Andrew Smith le 07 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Nomination d'un administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Administrateur
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish163496070001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Secrétaire
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secrétaire
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Secrétaire
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    158304690001
    MCLEISH, William David
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secrétaire
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    BIGGART BAILLIE & GIFFORD WS
    11 Glenfinlas Street
    Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire désigné
    11 Glenfinlas Street
    Edinburgh
    Lothian
    900005750001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Administrateur
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    BOLOT, Timothy James
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    Administrateur
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    American51593550001
    BUCHAN, William James
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Administrateur
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Administrateur
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    British76212360001
    DENNY, Nigel John
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    Administrateur
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    British53339290001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Administrateur
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    Administrateur
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Administrateur
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    GUEST, Walter Henry
    Spindleberry Pine Avenue
    GU15 2LY Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Spindleberry Pine Avenue
    GU15 2LY Camberley
    Surrey
    British4200040001
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Administrateur
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Administrateur
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Administrateur
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritish5579020001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Administrateur
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100131200001
    MIDMER, Richard Neil
    The Castle Business Park, Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    C/O Southern Cross Healthcare
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    The Castle Business Park, Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    C/O Southern Cross Healthcare
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Administrateur
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    PHIPPEN, Kent William
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    Administrateur
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    United KingdomAmerican84576560001

    ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of accession and charge
    Créé le 21 août 2008
    Livré le 03 sept. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due all sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 sept. 2008
    Legal charge
    Créé le 02 sept. 1996
    Livré le 18 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges.collingwood grange,portsmouth road,camberley,surrey. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 18 sept. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 févr. 1995
    Acquis le 03 févr. 1995
    Livré le 12 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due, or to become due
    Brèves mentions
    Annfield house, stirling, registered under title number stg 9911.
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 12 avr. 1995Enregistrement d'une acquisition (416)
    • 18 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 19 avr. 1994
    Livré le 22 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Broomcroft, ecclesall road, south sheffield, south yorkshire.... See ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • Electra Kingsway Limited as Agent and Trustee
    Transactions
    • 22 avr. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 09 juin 1993
    Livré le 25 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    174 norwich road, ipswich and 176-182 (even nos) norwich road, ipswich.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 juin 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 01 févr. 1993
    Acquis le 01 févr. 1993
    Livré le 11 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Broomcroft eccleshall road south sheffield and 12 other properties see paper apart 2.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 11 mars 1993Enregistrement d'une acquisition (416)
    • 19 févr. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 12 mars 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 03 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 12 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground at torr road, quarrier's village, bridge of weir registered title number ren 58217 together with the mines, minerals, metals and fossils within and under the said subjects but that only in so far as the company has right thereto, the whole buildings and other erections if any to be erected thereon, the heritable fittings and fixtures therein and thereon and the parts, pertinents and priveleges thereof.
    Personnes ayant droit
    • Electra Kingsway as Agent and Trustee
    Transactions
    • 12 févr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Fixed charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 04 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    A. by way of legal mortgage the mortaged propery as listed in the paper apart, together with all fixed plant and machinery and fixtures thereto. B. by way of specific equitable charge all estates or interests in any freehold or leasehold property (except the mortgaged property and any such property as may be situated in scotland) now or at any time during the subsistence of the charge belonging to or charged to the company.
    Personnes ayant droit
    • Electra Kingsway Limitedas Agent and Trustee for the Lenders
    Transactions
    • 04 févr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 04 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Electra Kingsway Limitedas Agent and Trustee for the Lenders
    Transactions
    • 04 févr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 févr. 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 déc. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 29 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 août 2012Date of completion or termination of CVA
    20 juin 2012Date of meeting to approve CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0