CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC141586 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o C/O BRUNTONS AERO PRODUCTS LIMITED Units 1-3 Block 1 Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Midlothian Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 27 juin 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2025 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Ian Alan Tichias en tant qu'administrateur le 01 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Eric George Hutchinson en tant que directeur le 31 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2024 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Carclo Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 juin 2024 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de David Michael Bedford en tant que directeur le 21 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Eric George Hutchinson en tant qu'administrateur le 21 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Statuts | 37 pages | MA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Angela Wakes en tant que secrétaire le 20 juin 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Lee George Westgarth en tant que directeur le 12 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr David Michael Bedford en tant qu'administrateur le 14 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Carclo Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 nov. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee George Westgarth le 09 oct. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICHIAS, Ian Alan | Administrateur | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | England | British | 334271160001 | |||||
| COLE, Richard Andrew | Secrétaire | PO BOX 88 27 Dewsbury Road WF5 9WS Ossett Springstone House England | 262035740001 | |||||||
| COOK, Eric | Secrétaire | 15 Chevet Lane Sandal WF2 6HN Wakefield West Yorkshire | British | 34100510003 | ||||||
| DUNCAN, James Crabb | Secrétaire | 20 Hawthorn Avenue PA8 7BU Erskine Renfrewshire | British | 58711040001 | ||||||
| HOBBS, Jeffrey Jacques | Secrétaire | 1 Cedar Copse BR1 2NY Bromley Kent | British | 3252730001 | ||||||
| LIDDLE, Matthew | Secrétaire | 54 High Street MK45 5DY Flitton Bedfordshire | British | 35090550001 | ||||||
| LONGHORN, James Grahame | Secrétaire | Ingelthorpe Cresswell Road TS26 0EG Hartlepool Cleveland | British | 42995300001 | ||||||
| OTTAWAY, Richard | Secrétaire | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | 199253800001 | |||||||
| WAKES, Angela | Secrétaire | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | 263104830001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secrétaire désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| ADAM, David William | Administrateur | 34 Gill Bank Road LS29 0AU Ilkley West Yorkshire | England | British | 106771550001 | |||||
| ADAMS, John Flannagan | Administrateur | 3 Strawberryfield Road Crosslee PA6 7LA Johnstone Renfrewshire | British | 35787770001 | ||||||
| BEDFORD, David Michael | Administrateur | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | England | British | 302295360001 | |||||
| CAMPBELL, Drew | Administrateur | 1 Stonefield Gardens PA2 7RH Paisley Renfrewshire | British | 69256200001 | ||||||
| COOK, Eric | Administrateur | 15 Chevet Lane Sandal WF2 6HN Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 34100510003 | |||||
| DUNCAN, James Crabb | Administrateur | 20 Hawthorn Avenue PA8 7BU Erskine Renfrewshire | British | 58711040001 | ||||||
| HASLEHURST, Peter Joseph Kinder | Administrateur | Old Crowholt Farm Cowbrook Lane Gawsworth SK11 0JH Macclesfield Cheshire | England | British | 39820040001 | |||||
| HOBBS, Jeffrey Jacques | Administrateur | 1 Cedar Copse BR1 2NY Bromley Kent | British | 3252730001 | ||||||
| HOBBS, Jeffrey Jacques | Administrateur | 1 Cedar Copse BR1 2NY Bromley Kent | British | 3252730001 | ||||||
| HUTCHINSON, Eric George | Administrateur | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | United Kingdom | British | 278361460001 | |||||
| KURWIE, Tiessir Shhab | Administrateur | 6 Kensington Road WF1 3JX Wakefield West Yorkshire | British | 63799580002 | ||||||
| LOGIE, Ian | Administrateur | 15 Fairways View Hardgate Glasgow | British | 35787830002 | ||||||
| MAWE, Christopher | Administrateur | 5 Back Lane Whixley YO26 8BG York North Yorkshire | British | 99084660001 | ||||||
| MAXTED, Tony | Administrateur | 25 Nursery Grove PA13 4HW Kilmacolm Renfrewshire | British | 69256170001 | ||||||
| MCDOUGAL, Ian Waddell | Administrateur | 10 Belford Grove Newton Mearns G77 5FB Glasgow Lanarkshire | British | 35787780002 | ||||||
| OTTAWAY, Richard John | Administrateur | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | England | British | 183149280001 | |||||
| REVILL, John Arthur | Administrateur | 43 Haworth Crescent Moorgate S60 3BW Rotherham South Yorkshire | British | 39565760003 | ||||||
| SALT, Roger | Administrateur | 55 Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RT Dronfield Derbyshire | England | British | 172092330001 | |||||
| WALTON, Neil | Administrateur | Bankfoot Farm Ingleby Greenhow TS9 6LP Middlesbrough Cleveland | England | British | 33358380001 | |||||
| WARDROP, Robert | Administrateur | 49 St Annes Wynd PA8 7DT Erskine Renfrewshire | British | 58710990001 | ||||||
| WESTGARTH, Lee George | Administrateur | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | England | British | 262033110002 | |||||
| WILLIAMSON, Ian | Administrateur | Longmeadow 10 Edmunton Way LE15 6JE Oakham Rutland Leicester | England | British | 43077420001 | |||||
| WORMSLEY, Bertram Howard | Administrateur | 69 Hervey Road Blackheath SE3 8BX London | British | 3252750001 | ||||||
| YOUNG, Peter James | Administrateur | Mathon House Mathon WR13 5PW Malvern Worcestershire | British | 18300970002 | ||||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Administrateur désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carclo Plc | 06 avr. 2016 | Wates Way CR4 4HR Mitcham 47 Surrey United Kingdom | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0