MACRAE FOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACRAE FOODS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC141744
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACRAE FOODS LIMITED ?

    • Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques (10200) / Industries manufacturières

    Où se situe MACRAE FOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    319 St. Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MACRAE FOODS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MOUNTWEST ONE LIMITED16 déc. 199216 déc. 1992

    Quels sont les derniers comptes de MACRAE FOODS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour MACRAE FOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    7 pagesLIQ13(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG à 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS le 14 mai 2021

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Watermill Road Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9HA à C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG le 17 juil. 2020

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 juil. 2020

    LRESSP

    État du capital au 09 avr. 2020

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 18/03/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Déclaration de confirmation établie le 16 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Jenny Nancy Loncaster en tant que directeur le 25 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Mark Busby en tant que directeur le 12 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2019 au 31 mars 2020

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont en tant qu'administrateur le 04 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 04 juil. 2019

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 16 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Wilkin Chapman Company Secretarial Service Ltd le 19 nov. 2018

    1 pagesCH04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Malcolm Herbert Lofts en tant que directeur le 31 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Timothy Mark Busby en tant qu'administrateur le 31 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Malcolm Herbert Lofts en tant que directeur le 31 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 16 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 déc. 2016 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de MACRAE FOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons
    St. Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    319
    Administrateur
    St. Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    319
    United KingdomBelgian231792890001
    GAULT, Sandra
    25 Pitblae Gardens
    AB43 7BH Fraserburgh
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    25 Pitblae Gardens
    AB43 7BH Fraserburgh
    Aberdeenshire
    British61174690002
    STRONACHS
    34 Albyn Place
    AB10 1FW Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire désigné
    34 Albyn Place
    AB10 1FW Aberdeen
    Aberdeenshire
    900000500001
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Secrétaire désigné
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2249348
    900013350001
    ALLAN, David Martin
    Silverdale South Avenue
    Cults
    AB15 9LP Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Silverdale South Avenue
    Cults
    AB15 9LP Aberdeen
    Aberdeenshire
    British41797230002
    ANDERSON, Stuart Anthony Kidston
    Allee Du Cloitre 7
    FOREIGN Brussels
    1000
    Belgium
    Administrateur
    Allee Du Cloitre 7
    FOREIGN Brussels
    1000
    Belgium
    British71513420001
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Administrateur
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    BROWN, Cameron Matthew
    26 St Clair Wynd
    Newburgh
    AB41 6DZ Ellon
    Aberdeenshire
    Administrateur
    26 St Clair Wynd
    Newburgh
    AB41 6DZ Ellon
    Aberdeenshire
    British61176080001
    BUSBY, Timothy Mark
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    Administrateur
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    EnglandEnglish169852920001
    DEN HOLLANDER, Leendert Pieter
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    Administrateur
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    EnglandDutch166335910001
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanish127032620001
    HAZELDEAN, James William
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish10359650007
    KNUTTON, Roderick Leonard
    Loanhead Of Pitinnan
    Daviot
    AB51 0JH Inverurie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Loanhead Of Pitinnan
    Daviot
    AB51 0JH Inverurie
    Aberdeenshire
    British35167880001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    Administrateur
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    EnglandBritish177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    Administrateur
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    EnglandBritish185293570001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Administrateur
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    PORTEOUS, Ronald
    Coirseunan Lodge
    Whitecairns
    AB23 8UN Aberdeen
    Administrateur
    Coirseunan Lodge
    Whitecairns
    AB23 8UN Aberdeen
    British42171410001
    WRIGHT, Robin James Morrison
    7 Buckland Gate
    Wexham
    SL3 6LS Slough
    Berkshire
    Administrateur
    7 Buckland Gate
    Wexham
    SL3 6LS Slough
    Berkshire
    United KingdomBritish71513490001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACRAE FOODS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    06 avr. 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03751665
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MACRAE FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 06 nov. 2008
    Livré le 19 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects lying on the north side of watermill road, fraserburgh, aberdeen ABN59533.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 19 nov. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 oct. 2008
    Livré le 05 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 05 nov. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 sept. 2008
    Livré le 03 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 03 oct. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 04 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects lying on the north side of watermill road, fraserburgh ABN59533.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 04 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Debenture
    Créé le 21 mars 2007
    Livré le 31 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent
    Transactions
    • 31 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 28 oct. 2008
    Standard security
    Créé le 28 mars 2006
    Livré le 31 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the finance documents
    Brèves mentions
    The subjects lying on the north side of watermill road, fraserburgh (title number abn 59533).
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 31 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Debenture
    Créé le 16 mars 2006
    Livré le 29 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the finance documents
    Brèves mentions
    First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 29 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 2008
    • 28 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 12 déc. 2005
    Livré le 20 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 20 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 déc. 2005
    Livré le 28 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects on north side of watermill road, fraserburgh ABN59533.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 28 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 juil. 2004
    Livré le 22 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjectas lying on the northside of watermill road, fraserburgh--title number ABN59533.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 22 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 30 juin 2004
    Livré le 10 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 10 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 04 août 2000
    Livré le 15 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 04 août 2000
    Livré le 15 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 22 févr. 1993
    Livré le 03 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 mars 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    MACRAE FOODS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 juil. 2020Commencement of winding up
    15 janv. 2022Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0