C.F.M. BUILDING SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | C.F.M. BUILDING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC142595 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe C.F.M. BUILDING SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 33-35 Mcfarlane Street Paisley PA3 1SA Scotland United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de C.F.M. BUILDING SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour C.F.M. BUILDING SERVICES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 oct. 2025 |
Quels sont les derniers dépôts pour C.F.M. BUILDING SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Precision House Mcneil Drive Motherwell Scotland ML1 4UR Scotland à 33-35 Mcfarlane Street Paisley Scotland PA3 1SA le 23 janv. 2025 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 17 pages | AA | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 27 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Démission de l'auditeur | 4 pages | AUD | ||
Cessation de la nomination de Richard James Ward en tant que directeur le 31 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 28 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Latham Nelson le 25 nov. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 30 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard James Ward le 30 juil. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 29 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Southside House 135 Fifty Pitches Road Carnold Business Park Glasgow G51 4EB Scotland à Precision House Mcneil Drive Motherwell Scotland ML1 4UR le 05 oct. 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Nomination de Mr Craig Matthew Mcgilvray en tant qu'administrateur le 15 janv. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Amanda Lucia Fisher en tant que directeur le 15 janv. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Lee Milner en tant que directeur le 12 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 27 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de C.F.M. BUILDING SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| MCGILVRAY, Craig Matthew | Administrateur | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | Scotland | British | 58993260002 | |||||||||
| NELSON, Andrew Latham | Administrateur | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | 36191090004 | |||||||||
| BIRCH, Paul | Secrétaire | c/o Enterprise Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire | British | 153471240001 | ||||||||||
| FINLAYSON, Elizabeth Cairns | Secrétaire | 40 Old Lanark Road ML8 4HW Carluke Lanarkshire | British | 38835360001 | ||||||||||
| GREENSHIELDS, George | Secrétaire | 16 Sutherland Drive Cairnhill ML6 9RP Airdrie Lanarkshire | British | 32923540001 | ||||||||||
| REID, Brian | Secrétaire désigné | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||||||
| ATHERTON, David | Administrateur | 142 Speke Road Garston L19 2PH Liverpool Amey - The Matchworks England | England | British | 109058740001 | |||||||||
| CHASTON, Stuart Paul | Administrateur | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancs United Kingdom | United Kingdom | British | 171463320001 | |||||||||
| DALEY, John Christopher | Administrateur | 1 Silverwood Court Langside Road Bothwell Lanarkshire | British | 45269730001 | ||||||||||
| DUGGAN, Gillian | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 135453240001 | |||||||||
| EWELL, Melvyn | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 61515760002 | |||||||||
| FINLAYSON, Kenneth | Administrateur | 40 Old Lanark Road ML8 4HW Carluke Lanarkshire | Scotland | British | 271940001 | |||||||||
| FISHER, Amanda Lucia | Administrateur | c/o Corporate Services Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | United Kingdom | British | 237867440001 | |||||||||
| FLOOD, John Joseph | Administrateur | c/o Enterprise Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 73695830003 | |||||||||
| FRASER, Ian Ellis | Administrateur | c/o Enterprise Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | Scotland | Uk | 28393850006 | |||||||||
| GREENSHIELDS, George | Administrateur | 16 Sutherland Drive Cairnhill ML6 9RP Airdrie Lanarkshire | British | 32923540001 | ||||||||||
| GREGG, Nicholas Mark | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building Oxfordshire England | England | British | 144667000001 | |||||||||
| HALL, Philip Gregory | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Gordon House | United Kingdom | British | 68223860003 | |||||||||
| HOLLAND, Daniel Lawrence | Administrateur | 20 Colmore Circus Queensway B4 6AT Birmingham Colmore Plaza England | England | British | 94444730003 | |||||||||
| JOYCE, Martin John | Administrateur | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House | England | British | 72254420003 | |||||||||
| MABBOTT, Stephen | Administrateur désigné | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow Strathclyde | British | 900007110001 | ||||||||||
| MILNER, Andrew Lee | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 133714170002 | |||||||||
| WARD, Richard James | Administrateur | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | United Kingdom | British | 184818190001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur C.F.M. BUILDING SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Managed Services Limited | 06 avr. 2016 | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0