BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED

BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC142783
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4th Floor 115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Terrace Hill (Secretaries) Limited le 28 oct. 2015

    1 pagesCH04

    État du capital au 17 sept. 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Alexander Jeremy Leech le 08 juin 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Martin Austen le 08 juin 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 févr. 2015

    État du capital au 23 févr. 2015

    • Capital: GBP 40,400
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2013

    13 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 24 Great King Street Edinburgh EH3 6QN* le 23 avr. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 févr. 2014

    État du capital au 28 févr. 2014

    • Capital: GBP 40,400
    SH01

    Nomination de Mr Jonathan Martin Austen en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Thomas Walsh en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Philip Alexander Jeremy Leech en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Miranda Kelly en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Qui sont les dirigeants de BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    URBAN&CIVIC (SECRETARIES) LIMITED
    115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC154216
    41006000014
    AUSTEN, Jonathan Martin
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    Administrateur
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director51921200001
    LEECH, Philip Alexander Jeremy
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    Administrateur
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector77080490002
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Secrétaire
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Secrétaire
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Secrétaire
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    British1500260013
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    QUILL SERVE LIMITED
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Secrétaire désigné
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    900003050001
    CUFLEY, Sean Dominic Hardy
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant9150920001
    DONNELLY, Anthony
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    Administrateur
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    United KingdomBritishDevelopment Director109258700001
    HOWELL, Keith Martin
    Woodbine Cottage Main Street
    EH46 7EA West Linton
    Borders
    Scotland
    Administrateur
    Woodbine Cottage Main Street
    EH46 7EA West Linton
    Borders
    Scotland
    BritishFinance Director1499960004
    HUTCHISON, Graeme
    11 West Savile Gardens
    EH9 3AB Edinburgh
    Administrateur
    11 West Savile Gardens
    EH9 3AB Edinburgh
    BritishBanker38185540002
    IRONSIDE, Ronald Alexander Hamilton
    24 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    24 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant296250001
    KELLY, Miranda Anne
    21 Rozelle Avenue
    Waterside, Newton Mearns
    G77 6YS Glasgow
    Administrateur
    21 Rozelle Avenue
    Waterside, Newton Mearns
    G77 6YS Glasgow
    ScotlandBritishSolicitor62817160003
    LAW, William Blyth
    Loanstone Crossing
    Loanstone
    EH26 8PH Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    Loanstone Crossing
    Loanstone
    EH26 8PH Penicuik
    Midlothian
    BritishHousing Manager33622620002
    LEITH, Brian James
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    Administrateur
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    BritishCompany Director61660001
    LEITH, Brian James
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    Administrateur
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    BritishCompany Director61660001
    MACDONALD, Donald Ross
    Flat 2r, 37 Bellshaugh Gardens
    Kelvinside
    G12 0SA Glasgow
    Administrateur
    Flat 2r, 37 Bellshaugh Gardens
    Kelvinside
    G12 0SA Glasgow
    United KingdomBritishSolicitor76786510001
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Administrateur
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritishBank Official190466700001
    MCDOUGALL, Alastair Douglas
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    Administrateur
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    ScotlandBritishCompany Director33622580001
    MCDOWALL, June Patricia
    139 Hamilton Road
    Rutherglen
    G73 3BE Glasgow
    Administrateur
    139 Hamilton Road
    Rutherglen
    G73 3BE Glasgow
    United KingdomBritishCompany Registrar50316470001
    MIDDLETON, Douglas Alister
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    Administrateur
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    BritishChartered Accountant73738070001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Administrateur
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    BritishCompany Secretary1500260013
    PRICHARD, Kim Alan
    24 Pentland Gardens
    EH10 6NW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    24 Pentland Gardens
    EH10 6NW Edinburgh
    Midlothian
    BritishProperty Developer72744060002
    ROBB, Gordon William
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant11456230001
    WALSH, Thomas Gerard
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    Administrateur
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    EnglandIrishAccountant48520230001
    WILSON, Alistair Barclay
    19 Cauldstream Place
    Milngavie
    G62 7NL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    19 Cauldstream Place
    Milngavie
    G62 7NL Glasgow
    Lanarkshire
    BritishAccountant426640001
    QUILL FORM LIMITED
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Administrateur désigné
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    900003040001

    BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground lying in the parish of belhelvie and county of aberdeen extending to 1 acre 685 decimla or one thousandth parts of an acre.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mars 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 11 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    34,36,40,42,44,46,48 & 49 high mill, high mill court, dundee; 25C, 25A,23B, 21A,21B,11A,15A,15B,17A,17B,19A,19B & 43C taylors lane, dundee.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 10 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Flatted dwellinghouses known as 256, 258, 259, 264 and 265 (also known as 2, 6, 8, 18 and 20) castle heather drive, inverness and those plots or areas of ground extending in total to 1071.20 square metres or thereby with the semi-detached dwellinghouse erected thereonknown as plots 268, 269, 272, 273, 415 and 417 (also known as 26, 28, 34, 36, 94 and 98) castle heather drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 10 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground lying to the east of castle heather drive, inverness together with whole buildings and other erections thereon being plots 232-255 castle heather drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mars 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 10 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.59 hectares of ground at orchard avenue and mossgiel road, ayr.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 06 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    25-31 high street, penicuik.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 06 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    6,7 & 8 grandfield, craighall road, newhaven.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mars 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 26 nov. 2001
    Livré le 29 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 29 nov. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 déc. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 déc. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 avr. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 05 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 11 oct. 1995
    Livré le 18 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 25-31 high street, penicuik in the county of midlothian.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 oct. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 oct. 1995
    Livré le 18 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects extending to fifty nine decimals or one hundreth parts of an hectare or thereby at orchard avenue and mossgiel road ayr.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 oct. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 oct. 1995
    Livré le 18 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects extending to one acre and six hundred and eighty five decimal or one thousandth parts of an acre or therebyat eigie crescent, balmedie in the parish of belhelvie and county of aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 oct. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 oct. 1995
    Livré le 06 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.59 gectares at orchard avenue and mossgiel road, ayr.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 oct. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 oct. 1995
    Livré le 06 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.685 acres at eigie crescent, balmedie, belhevie, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 oct. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 oct. 1995
    Livré le 06 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 25-31 high street, penicuik.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 oct. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 sept. 1995
    Livré le 05 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Piece of ground lying in the parish of belhevie, aberdeen, extending to 1.685 acres under exception....... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Homes
    Transactions
    • 05 oct. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Minute of agreement
    Créé le 04 avr. 1995
    Livré le 25 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The rights under a management agreement dated 31/3/95 between the company and adam housing society limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Minute of agreement
    Créé le 04 avr. 1995
    Livré le 25 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The rights under a management contract dated 31/3/95 between the company and adam housing society limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Minute of agreement
    Créé le 04 avr. 1995
    Livré le 07 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The company's rights under a minute of agreement dated 31/3/95
    Brèves mentions
    The management contract.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Minute of agreement
    Créé le 04 avr. 1995
    Livré le 07 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The company's rights under a minute of agreement dated 31/3/95
    Brèves mentions
    The management contract.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 03 avr. 1995
    Livré le 07 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plots 256,258,259,264,264,268,269,272,273,415,417 and 420 castleheather, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Morrison Homes Limited
    Transactions
    • 07 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 avr. 1995
    Livré le 07 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plots 9,33,35 and 36 balfour's green, carronshore.
    Personnes ayant droit
    • Morrison Homes Limited
    Transactions
    • 07 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 avr. 1995
    Livré le 04 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Castle heather development balloan road, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 avr. 1995
    Livré le 04 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    15 duncan avenue and 1, 3 & 4 rae court, carronvale.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 févr. 1995
    Livré le 23 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.59 ha orchard avenue, ayr.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Homes
    Transactions
    • 23 févr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 24 janv. 1995
    Livré le 25 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due and to become due in terms of a personal bond dated 17/8/93
    Brèves mentions
    Area of ground lying generally to the east and south of castle heather drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 janv. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0