THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED

THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC143071
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o HBJ GATELEY
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE MALMAISON HOTEL LIMITED17 juin 199317 juin 1993
    COMLAW NO. 319 LIMITED05 mars 199305 mars 1993

    Quels sont les derniers comptes de THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge SC1430710035 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1430710036 en totalité

    4 pagesMR04

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2016 au 30 sept. 2016

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Roberts le 11 mai 2016

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 mars 2016

    État du capital au 17 mars 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Gary Reginald Davis en tant que directeur le 17 juin 2015

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge SC1430710038 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1430710037 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mars 2015

    État du capital au 26 mars 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge SC1430710035

    5 pagesMR05

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge SC1430710037

    5 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge SC1430710036

    5 pagesMR05

    Cessation de la nomination de as Company Services Limited en tant que secrétaire le 31 août 2014

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de 1 Rutland Court Edinburgh EH3 8EY à C/O Hbj Gateley Exchange Tower 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EH le 12 sept. 2014

    1 pagesAD01

    État du capital au 29 mai 2014

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Qui sont les dirigeants de THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROBERTS, Paul
    Fleet Place
    EC4M 7WS London
    1
    England
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7WS London
    1
    England
    United KingdomBritish168184220001
    BONELLA, Richard John Murray
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    British33446940002
    BRUCE, Graeme Murray
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Secrétaire désigné
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002440001
    ROBSON, Gail
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    British100895090001
    TUTTY, Roy James
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61146650001
    AS COMPANY SERVICES LIMITED
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Secrétaire
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC316974
    119906300001
    FILEX SERVICES LIMITED
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02566556
    3620420001
    SF SECRETARIES LIMITED
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Secrétaire
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC128549
    152751750001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Administrateur
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BATE, Simon Donald
    27 Southdowns Road
    WA14 3NP Bowden
    Altrincham
    Administrateur
    27 Southdowns Road
    WA14 3NP Bowden
    Altrincham
    British75874130002
    BIBRING, Michael Albert
    Hive Road
    WD2 1JG Bushey Heath
    Conifers
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Hive Road
    WD2 1JG Bushey Heath
    Conifers
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish9320160002
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLACK, Robin Kennedy
    Nevergood Farmhouse
    Brick Kiln Lane
    TN12 8ES Horsmonden
    Kent
    Administrateur
    Nevergood Farmhouse
    Brick Kiln Lane
    TN12 8ES Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritish37965380001
    BLUM, Edward Jesse
    63 Denton Road
    TW1 2TN Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    63 Denton Road
    TW1 2TN Twickenham
    Middlesex
    American65674420001
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish53724380001
    BLURTON, Andrew Francis
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish53724380001
    BOHLMANN, John
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    Administrateur
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    American65674380001
    BREARE, Robert Roddick Ackrill
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    Administrateur
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    British38255700004
    BRUCE, Graeme Murray
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Administrateur désigné
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002440001
    CARREKER, James Don
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    Administrateur
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    American66262660001
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish102741680001
    COOK, Robert Barclay
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    Administrateur
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    United KingdomBritish136758210001
    DAVIS, Gary Reginald
    Curtiss House
    27 Heritage Avenue
    NW9 5WT London
    Flat 66
    England
    Administrateur
    Curtiss House
    27 Heritage Avenue
    NW9 5WT London
    Flat 66
    England
    EnglandBritish167510270002
    DODD, Andrew Gerard
    96 Park Road
    WA15 9LF Hale
    Cheshire
    Administrateur
    96 Park Road
    WA15 9LF Hale
    Cheshire
    EnglandBritish74768570001
    ELLIOT, Colin David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish154267590001
    GALBRAITH, Eric Roger
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Administrateur désigné
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002450001
    HAINING, Andrew
    21 Stratford Grove
    SW15 1NU London
    Administrateur
    21 Stratford Grove
    SW15 1NU London
    British42196640008
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Administrateur
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    MCCULLOCH, Kenneth Wilfred
    69 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    Administrateur
    69 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    ScotlandBritish37947170001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritish132613500001
    PRIESTLEY, Jeremy Robert
    8 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    Administrateur
    8 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    EnglandBritish766060001
    RAYMOND, Anne
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    Administrateur
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    American66261390001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Administrateur
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    Administrateur
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritish121710890001
    TUTTY, Roy James
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61146650001

    THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 avr. 2014
    Livré le 17 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    278 west george street glasgow GLA104489 and 160 pitt street glasgow GLA104488.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 nov. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 30 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 avr. 2014
    Livré le 17 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    278 west george street glasgow and 160 pitt street glasgow GLA193266 & GLA193265.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 nov. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 30 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 avr. 2014
    Livré le 15 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 avr. 2014
    Livré le 11 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All intellectual property, all estates or interest in any freehold or leasehold property, all of the chargors rights and interests in any lease document.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 nov. 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 22 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 15 avr. 2008
    Livré le 22 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 28 juin 2006
    Livré le 17 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The companys interest in a lease of the land and buildings erected thereon known as malmaison glasgow, 160 pitt street and 278 west george street, glasgow GLA104488 GLA104489.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 juil. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 juin 2003
    Livré le 23 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    160 pitt street & 278 west george street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC
    Transactions
    • 23 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 03 juin 2003
    Livré le 20 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC as Security Agent
    Transactions
    • 20 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 mai 2003
    Livré le 10 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC as Security Agent
    Transactions
    • 10 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of standard security
    Créé le 08 juil. 2002
    Livré le 17 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to the financing documents
    Brèves mentions
    160 pitt street and 278 west george street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 08 juil. 2002
    Livré le 17 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond dated 26 june 2002
    Brèves mentions
    160 pitt street and 278 west george street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 juin 2002
    Livré le 08 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Charge over construction documentation
    Créé le 02 juin 2002
    Livré le 22 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charge over the company's right, title and interest in the construction documentation.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 juin 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 mars 2001
    Livré le 03 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations as contained in the agreement
    Brèves mentions
    160 pitt street and 278 west george street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Hotel Invest UK a/S
    Transactions
    • 03 avr. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 nov. 2000
    Livré le 21 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    160 pitt street, glasgow and 278 west george street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Trustee
    Transactions
    • 21 nov. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 03 nov. 2000
    Livré le 23 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hotel Invest UK a/S
    Transactions
    • 23 nov. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 03 nov. 2000
    Livré le 23 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hotel Invest UK a/S
    Transactions
    • 23 nov. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 03 nov. 2000
    Livré le 21 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charge over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Trustee
    Transactions
    • 21 nov. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 nov. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 03 nov. 2000
    Livré le 21 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Trustee
    Transactions
    • 21 nov. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 nov. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 10 avr. 1997
    Livré le 17 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    278 west george street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 17 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 avr. 1997
    Livré le 17 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    160 pitt street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 17 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 02 avr. 1997
    Livré le 14 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company as Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transactions
    • 14 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 02 avr. 1997
    Livré le 10 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 10 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 avr. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 13 mars 1997
    Livré le 27 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    160 pitt street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Arcadian International PLC
    Transactions
    • 27 mars 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 mars 1997
    Livré le 27 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    278 west george street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Arcadian International PLC
    Transactions
    • 27 mars 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0