TIGER (NOMINEES) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTIGER (NOMINEES) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC143948
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TIGER (NOMINEES) LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe TIGER (NOMINEES) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Collins House
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TIGER (NOMINEES) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHANCERYGATE (AA) PROPERTIES LIMITED07 août 200207 août 2002
    CHANCERYGATE SUON PROPERTIES LIMITED11 juil. 200211 juil. 2002
    CARISBROOKE SUON PROPERTIES LIMITED14 oct. 199814 oct. 1998
    WEST REGISTER (P.I.3) LIMITED12 mai 199312 mai 1993
    ROBOSCOT (8) LIMITED20 avr. 199320 avr. 1993

    Quels sont les derniers comptes de TIGER (NOMINEES) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour TIGER (NOMINEES) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mai 2016

    État du capital au 02 mai 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    14 pagesAA

    Nomination de Michael Joseph O'flynn en tant qu'administrateur le 28 oct. 2015

    3 pagesAP01

    Nomination de John Oliver Nesbitt en tant qu'administrateur le 28 oct. 2015

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon David Austin Davies en tant que directeur le 28 oct. 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Robert Lock en tant que directeur le 28 oct. 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gordon Robert Mckie en tant que directeur le 28 oct. 2015

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juin 2015

    État du capital au 11 juin 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mr. Simon David Austin Davies en tant qu'administrateur le 25 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Joseph O'flynn en tant que directeur le 25 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Oliver Nesbitt en tant que directeur le 25 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Kelleher en tant que directeur le 25 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr. Gordon Robert Mckie en tant qu'administrateur le 25 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr. James Robert Lock en tant qu'administrateur le 25 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Thomas Anthony Barry en tant que secrétaire le 01 mars 2015

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de TIGER (NOMINEES) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NESBITT, John Oliver
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    Administrateur
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    United KingdomBritishNone203614990001
    O'FLYNN, Michael Joseph
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Administrateur
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    IrelandIrishNone203653720001
    BARRY, Thomas Anthony
    Gurraun North
    IRISH Donoughmore
    County Cork
    Ireland
    Secrétaire
    Gurraun North
    IRISH Donoughmore
    County Cork
    Ireland
    IrishAccountant116825710001
    MACGILLIVRAY, Shirley Margaret
    52 Erskine Road
    EH52 6XL Broxburn
    West Lothian
    Secrétaire
    52 Erskine Road
    EH52 6XL Broxburn
    West Lothian
    British40027890001
    MAHENDRA, Myron Murugendra
    9 Wellesley Road
    Chiswick
    W4 4BS London
    Secrétaire
    9 Wellesley Road
    Chiswick
    W4 4BS London
    British62660140005
    MILLS, Alan Ewing
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    Secrétaire
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    British1268780001
    O'NEILL, Brian
    7 Woodbrook
    Rochestown Road
    IRISH Cork
    Ireland
    Secrétaire
    7 Woodbrook
    Rochestown Road
    IRISH Cork
    Ireland
    Irish87734240001
    PHOENIX, Christopher John
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    BritishAccountant16220320001
    BARRY, Thomas Anthony
    Gurraun North
    IRISH Donoughmore
    County Cork
    Ireland
    Administrateur
    Gurraun North
    IRISH Donoughmore
    County Cork
    Ireland
    IrelandIrishAccountant116825710001
    BEATTIE, Robert Henry
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBank Official27224590001
    BEATTIE, Robert Henry
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBank Official27224590001
    BHATIA, Kamal
    5 Highfields Grove
    Fitzroy Park
    N6 6HN London
    Administrateur
    5 Highfields Grove
    Fitzroy Park
    N6 6HN London
    EnglandIndianProperty Consultant82610530001
    CARTLEDGE, David Edmund
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    BritishBank Official38897330001
    DAVIES, Simon David Austin
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Administrateur
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    United KingdomBritishManaging Director197508390001
    FOSTER, Kennedy Campbell
    4 Deacons Court
    EH49 6BT Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    4 Deacons Court
    EH49 6BT Linlithgow
    West Lothian
    BritishCompany Secretary70070530001
    JOHNSON, Andrew William
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector68089410003
    KELLEHER, Michael
    Clifford Street
    W1S 2FT London
    9
    England
    Administrateur
    Clifford Street
    W1S 2FT London
    9
    England
    IrelandIrishDirector99150420001
    LEE, Peter John Gorringe
    South Park Farm
    Lower South Park
    RH9 8LF South Godstone
    Surrey
    Administrateur
    South Park Farm
    Lower South Park
    RH9 8LF South Godstone
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor83600080001
    LEWIS, Simon Nicholas Hewitt
    Bickley Court
    36 Chiselhurst Road
    BR1 2NW Bickley
    Kent
    Administrateur
    Bickley Court
    36 Chiselhurst Road
    BR1 2NW Bickley
    Kent
    United KingdomBritishChartered Surveyor60744980001
    LOCK, James Robert
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Administrateur
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    United KingdomBritishManaging Director195412690001
    MCKEAN, Alan Wallace
    141 Colinton Road
    EH14 1BG Edinburgh
    Administrateur
    141 Colinton Road
    EH14 1BG Edinburgh
    BritishBank Official1019950002
    MCKIE, Gordon Robert
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Administrateur
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    EnglandBritishManaging Director155757550001
    MELHUISH, Richard Marcus
    The Roundel
    Buncton Lane, Bolney
    RH17 5RE Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    The Roundel
    Buncton Lane, Bolney
    RH17 5RE Haywards Heath
    West Sussex
    BritishChartered Surveyor83530000001
    NESBITT, John Oliver
    Stoke Court
    Greete
    SY8 3BX Ludlow
    Shropshire
    Administrateur
    Stoke Court
    Greete
    SY8 3BX Ludlow
    Shropshire
    EnglandBritishDirector99542990002
    O NEIL, Brian
    7 Woodbrook
    IRISH Rochester Town
    Cork
    Ireland
    Administrateur
    7 Woodbrook
    IRISH Rochester Town
    Cork
    Ireland
    IrishCompany Director116920110001
    O'FLYNN, Michael Joseph
    Clifford Street
    W15 2FT London
    9
    England
    Administrateur
    Clifford Street
    W15 2FT London
    9
    England
    United KingdomIrishDirector19022840006
    PHOENIX, Christopher John
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritishAccountant16220320001
    SACH, Derek Stephen
    Warren Lodge
    32 Leigh Hill Road
    KT11 2HZ Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Warren Lodge
    32 Leigh Hill Road
    KT11 2HZ Cobham
    Surrey
    BritishBanker646390001
    SHEAVILLS, Ernest Michael
    Coombe House, 8 Westgarth Avenue
    Colinton
    EH13 0BD Edinburgh
    Administrateur
    Coombe House, 8 Westgarth Avenue
    Colinton
    EH13 0BD Edinburgh
    BritishBank Official34817880001
    SPEIRS, Robert
    17 Kings Crescent
    G84 7RB Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    17 Kings Crescent
    G84 7RB Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishGroup Finance Director2592770003
    TOUGH, Eric George William
    4 Doune Terrace
    EH3 6DY Edinburgh
    Administrateur
    4 Doune Terrace
    EH3 6DY Edinburgh
    BritishSolicitor54132470001
    WHITEHEAD, Grahame Taylor
    Southlea 20 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Administrateur
    Southlea 20 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    BritishBank Official1363570003
    WILLIAMS, John
    13 Doran Drive
    RH1 6AX Redhill
    Surrey
    Administrateur
    13 Doran Drive
    RH1 6AX Redhill
    Surrey
    BritishChartered Surveyor36333640001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TIGER (NOMINEES) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Tiger No2 General Partner Limited
    126-130 Regent Street
    W1B 5SE London
    Carrington House
    England
    20 avr. 2017
    126-130 Regent Street
    W1B 5SE London
    Carrington House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleEnglish
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    TIGER (NOMINEES) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 03 août 2004
    Livré le 10 août 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property at 59-61 high road, wood green, london--title number EGL219750 (see mortgage document for full listing of properties); fixed cahrges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 10 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 22 juil. 2004
    Livré le 30 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    52-58 high street, 5-13 cross wynd and 25-33 queen anne street, dunfermline--title number FFE10416.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 30 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 09 juil. 2004
    Livré le 30 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    52-58 high street, 5-13 cross wynd and 25-33 queen anne street, dunfermline.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 30 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 15 juil. 2002
    Livré le 24 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002
    Brèves mentions
    Ground floor shop premises known as 39 and 41 king street, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 15 juil. 2002
    Livré le 24 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002
    Brèves mentions
    The subjects 3 and 5 high street, paisley.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 15 juil. 2002
    Livré le 24 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002
    Brèves mentions
    Subjects forming 52-58 high street, 5/13 cross wynd & 25/33 queen anne street, dunfermline.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 15 juil. 2002
    Livré le 24 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002
    Brèves mentions
    Subjects forming 43 king street & 14 sandbed street, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 03 juil. 2002
    Livré le 17 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property and assets...see ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Crp General Partner Limited
    Transactions
    • 17 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 oct. 1998
    Livré le 22 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    43 king street & 14 sandbed street,kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 22 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 oct. 1998
    Livré le 22 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    52/58 high street,dunfermline.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 22 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 oct. 1998
    Livré le 22 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    39/41 king street,kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 22 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 oct. 1998
    Livré le 22 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3 & 5 high street,paisley.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 22 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of rents
    Créé le 15 oct. 1998
    Livré le 22 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    43 king street & 14 sandbed street,kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 22 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of rents
    Créé le 15 oct. 1998
    Livré le 22 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    39/41 king street,kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 22 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of rents
    Créé le 15 oct. 1998
    Livré le 22 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3 & 5 high street,paisley.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 22 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of rents
    Créé le 15 oct. 1998
    Livré le 22 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    52/58 high street,dunfermline.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 22 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 13 oct. 1998
    Livré le 03 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 03 nov. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 13 oct. 1998
    Livré le 03 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Veriensbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 03 nov. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0