TIGER (NOMINEES) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | TIGER (NOMINEES) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC143948 |
Juridiction | Écosse |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TIGER (NOMINEES) LIMITED ?
Adresse du siège social | Collins House Rutland Square EH1 2AA Edinburgh |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TIGER (NOMINEES) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour TIGER (NOMINEES) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2019 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 avr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2018 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2017 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2016 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2015 | 14 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Michael Joseph O'flynn en tant qu'administrateur le 28 oct. 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de John Oliver Nesbitt en tant qu'administrateur le 28 oct. 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon David Austin Davies en tant que directeur le 28 oct. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Robert Lock en tant que directeur le 28 oct. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gordon Robert Mckie en tant que directeur le 28 oct. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr. Simon David Austin Davies en tant qu'administrateur le 25 avr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Joseph O'flynn en tant que directeur le 25 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Oliver Nesbitt en tant que directeur le 25 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Kelleher en tant que directeur le 25 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr. Gordon Robert Mckie en tant qu'administrateur le 25 avr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr. James Robert Lock en tant qu'administrateur le 25 avr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Anthony Barry en tant que secrétaire le 01 mars 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TIGER (NOMINEES) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESBITT, John Oliver | Administrateur | Rutland Square EH1 2AA Edinburgh Collins House Scotland | United Kingdom | British | None | 203614990001 | ||||
O'FLYNN, Michael Joseph | Administrateur | Rutland Square EH1 2AA Edinburgh Collins House | Ireland | Irish | None | 203653720001 | ||||
BARRY, Thomas Anthony | Secrétaire | Gurraun North IRISH Donoughmore County Cork Ireland | Irish | Accountant | 116825710001 | |||||
MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Secrétaire | 52 Erskine Road EH52 6XL Broxburn West Lothian | British | 40027890001 | ||||||
MAHENDRA, Myron Murugendra | Secrétaire | 9 Wellesley Road Chiswick W4 4BS London | British | 62660140005 | ||||||
MILLS, Alan Ewing | Secrétaire | Sheriffs Park EH49 7SR Linlithgow 87 West Lothian | British | 1268780001 | ||||||
O'NEILL, Brian | Secrétaire | 7 Woodbrook Rochestown Road IRISH Cork Ireland | Irish | 87734240001 | ||||||
PHOENIX, Christopher John | Secrétaire | Mount Pleasant Farm Station Road Sturton Le Steeple DN22 9HS Retford Nottinghamshire | British | Accountant | 16220320001 | |||||
BARRY, Thomas Anthony | Administrateur | Gurraun North IRISH Donoughmore County Cork Ireland | Ireland | Irish | Accountant | 116825710001 | ||||
BEATTIE, Robert Henry | Administrateur | 10 Swanston Green EH10 7EW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Bank Official | 27224590001 | ||||
BEATTIE, Robert Henry | Administrateur | 10 Swanston Green EH10 7EW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Bank Official | 27224590001 | ||||
BHATIA, Kamal | Administrateur | 5 Highfields Grove Fitzroy Park N6 6HN London | England | Indian | Property Consultant | 82610530001 | ||||
CARTLEDGE, David Edmund | Administrateur | Raines Lodge Greenway CM13 2NR Brentwood Essex | British | Bank Official | 38897330001 | |||||
DAVIES, Simon David Austin | Administrateur | Berkeley Square W1J 5AL London 40 England | United Kingdom | British | Managing Director | 197508390001 | ||||
FOSTER, Kennedy Campbell | Administrateur | 4 Deacons Court EH49 6BT Linlithgow West Lothian | British | Company Secretary | 70070530001 | |||||
JOHNSON, Andrew William | Administrateur | Fulford Farm Culworth OX17 2HL Banbury Oxfordshire | England | British | Director | 68089410003 | ||||
KELLEHER, Michael | Administrateur | Clifford Street W1S 2FT London 9 England | Ireland | Irish | Director | 99150420001 | ||||
LEE, Peter John Gorringe | Administrateur | South Park Farm Lower South Park RH9 8LF South Godstone Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 83600080001 | ||||
LEWIS, Simon Nicholas Hewitt | Administrateur | Bickley Court 36 Chiselhurst Road BR1 2NW Bickley Kent | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 60744980001 | ||||
LOCK, James Robert | Administrateur | Berkeley Square W1J 5AL London 40 England | United Kingdom | British | Managing Director | 195412690001 | ||||
MCKEAN, Alan Wallace | Administrateur | 141 Colinton Road EH14 1BG Edinburgh | British | Bank Official | 1019950002 | |||||
MCKIE, Gordon Robert | Administrateur | Berkeley Square W1J 5AL London 40 England | England | British | Managing Director | 155757550001 | ||||
MELHUISH, Richard Marcus | Administrateur | The Roundel Buncton Lane, Bolney RH17 5RE Haywards Heath West Sussex | British | Chartered Surveyor | 83530000001 | |||||
NESBITT, John Oliver | Administrateur | Stoke Court Greete SY8 3BX Ludlow Shropshire | England | British | Director | 99542990002 | ||||
O NEIL, Brian | Administrateur | 7 Woodbrook IRISH Rochester Town Cork Ireland | Irish | Company Director | 116920110001 | |||||
O'FLYNN, Michael Joseph | Administrateur | Clifford Street W15 2FT London 9 England | United Kingdom | Irish | Director | 19022840006 | ||||
PHOENIX, Christopher John | Administrateur | Mount Pleasant Farm Station Road Sturton Le Steeple DN22 9HS Retford Nottinghamshire | England | British | Accountant | 16220320001 | ||||
SACH, Derek Stephen | Administrateur | Warren Lodge 32 Leigh Hill Road KT11 2HZ Cobham Surrey | British | Banker | 646390001 | |||||
SHEAVILLS, Ernest Michael | Administrateur | Coombe House, 8 Westgarth Avenue Colinton EH13 0BD Edinburgh | British | Bank Official | 34817880001 | |||||
SPEIRS, Robert | Administrateur | 17 Kings Crescent G84 7RB Helensburgh Dunbartonshire | British | Group Finance Director | 2592770003 | |||||
TOUGH, Eric George William | Administrateur | 4 Doune Terrace EH3 6DY Edinburgh | British | Solicitor | 54132470001 | |||||
WHITEHEAD, Grahame Taylor | Administrateur | Southlea 20 Cammo Crescent EH4 8DZ Edinburgh | British | Bank Official | 1363570003 | |||||
WILLIAMS, John | Administrateur | 13 Doran Drive RH1 6AX Redhill Surrey | British | Chartered Surveyor | 36333640001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TIGER (NOMINEES) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiger No2 General Partner Limited | 20 avr. 2017 | 126-130 Regent Street W1B 5SE London Carrington House England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
TIGER (NOMINEES) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Créé le 03 août 2004 Livré le 10 août 2004 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over property at 59-61 high road, wood green, london--title number EGL219750 (see mortgage document for full listing of properties); fixed cahrges over assets; floating charge over same. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 22 juil. 2004 Livré le 30 juil. 2004 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 52-58 high street, 5-13 cross wynd and 25-33 queen anne street, dunfermline--title number FFE10416. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignation of rents | Créé le 09 juil. 2004 Livré le 30 juil. 2004 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 52-58 high street, 5-13 cross wynd and 25-33 queen anne street, dunfermline. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 15 juil. 2002 Livré le 24 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002 | |
Brèves mentions Ground floor shop premises known as 39 and 41 king street, kilmarnock. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 15 juil. 2002 Livré le 24 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002 | |
Brèves mentions The subjects 3 and 5 high street, paisley. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 15 juil. 2002 Livré le 24 juil. 2002 | En cours | Montant garanti All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002 | |
Brèves mentions Subjects forming 52-58 high street, 5/13 cross wynd & 25/33 queen anne street, dunfermline. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 15 juil. 2002 Livré le 24 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002 | |
Brèves mentions Subjects forming 43 king street & 14 sandbed street, kilmarnock. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 03 juil. 2002 Livré le 17 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over the property and assets...see ch microfiche for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 20 oct. 1998 Livré le 22 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 43 king street & 14 sandbed street,kilmarnock. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 20 oct. 1998 Livré le 22 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 52/58 high street,dunfermline. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 20 oct. 1998 Livré le 22 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 39/41 king street,kilmarnock. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 20 oct. 1998 Livré le 22 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 3 & 5 high street,paisley. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignation of rents | Créé le 15 oct. 1998 Livré le 22 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 43 king street & 14 sandbed street,kilmarnock. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignation of rents | Créé le 15 oct. 1998 Livré le 22 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 39/41 king street,kilmarnock. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignation of rents | Créé le 15 oct. 1998 Livré le 22 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 3 & 5 high street,paisley. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignation of rents | Créé le 15 oct. 1998 Livré le 22 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 52/58 high street,dunfermline. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 13 oct. 1998 Livré le 03 nov. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Bond & floating charge | Créé le 13 oct. 1998 Livré le 03 nov. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0