SCOTTISH REFUGEE COUNCIL
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SCOTTISH REFUGEE COUNCIL |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | SC145067 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
O ù se situe SCOTTISH REFUGEE COUNCIL ?
| Adresse du siège social | Portland House 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SCOTTISH REFUGEE COUNCIL ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SCOTTISH REFUGEE COUNCIL ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 05 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SCOTTISH REFUGEE COUNCIL ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Katharine Victoria Jones en tant que directeur le 04 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2025 | 52 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Deborah Shields en tant que directeur le 11 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Statuts | 26 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Donnelly en tant que directeur le 05 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rona Alexander en tant que directeur le 31 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Steven Joseph Mcmanus en tant qu'administrateur le 22 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Professor Michael Donnelly en tant qu'administrateur le 22 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Helen Russell en tant qu'administrateur le 22 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Aaliya Seyal en tant que directeur le 22 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Dominique Nduhura en tant que directeur le 22 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kazimir Pasiecznik Lyon en tant que directeur le 22 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024 | 54 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Vitalii Diakov en tant qu'administrateur le 07 déc. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Inamullah Akbari en tant qu'administrateur le 07 déc. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Ronald Tapiwa Hlabanai Tagwireyi en tant qu'administrateur le 07 déc. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Patricia Zaarour en tant que directeur le 07 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023 | 48 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr David Norman Simpson en tant qu'administrateur le 26 oct. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Louise Hunter en tant que directeur le 26 oct. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mohamed Omar en tant que directeur le 26 oct. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SCOTTISH REFUGEE COUNCIL ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIDSON CHALMERS STEWART (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED | Secrétaire | Hope Street EH2 4DB Edinburgh 12 - 16 Scotland |
| 137092310002 | ||||||||||
| AKBARI, Inamullah | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | Afghan | 317035960001 | |||||||||
| CHIBHAMU, Alvina Tamara | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | Zimbabwean | 280260240001 | |||||||||
| DIAKOV, Vitalii | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | Ukrainian | 316106920001 | |||||||||
| GOODMAN, Lainé | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | British | 296796280001 | |||||||||
| LAWTON, Linda Anne | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | British | 99842580001 | |||||||||
| MCMANUS, Steven Joseph | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | British | 328833780001 | |||||||||
| RUSSELL, Helen | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | British | 328833580001 | |||||||||
| SIMPSON, David Norman | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | British | 315502890001 | |||||||||
| TAGWIREYI, Ronald Tapiwa Hlabanai | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | Zimbabwean | 288979240001 | |||||||||
| MATTHEWS, Edward Arthur | Secrétaire | 35 Temple Village EH23 4SQ Gore Bridge Midlothian | British | 685620001 | ||||||||||
| RYDER, Elizabeth Jane | Secrétaire | 26 Nelson Street EH3 6LJ Edinburgh Midlothian | British | 33015780001 | ||||||||||
| DAVIDSON CHALMERS (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED | Secrétaire | 12 Hope Street EH2 4DB Edinburgh Midlothian | 137092310001 | |||||||||||
| AL-ARASHI, Huda | Administrateur | Flat 1/4, 24 Dixon Avenue 2/M, Govanhill G42 8EE Glasgow | British | 76624000002 | ||||||||||
| AL-RIKABI, Ali | Administrateur | 12 Hope Street Edinburgh EH2 4DB Midlothian | Scotland | Iraqi | 178510130001 | |||||||||
| AL-SABBAGH, Sanaa Khalil | Administrateur | 12 Hope Street Edinburgh EH2 4DB Midlothian | Sudanese | 139713970002 | ||||||||||
| ALEXANDER, Rona | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | British | 113351150001 | |||||||||
| BHATIA, Monish, Dr | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | British | 204460730001 | |||||||||
| BOLT, Kathleen Janet | Administrateur | 1 Mentone Avenue Portobello EH15 1HZ Edinburgh | British | 43217910002 | ||||||||||
| BROWN, Julia Mary | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | Scottish | 65822270002 | |||||||||
| CAMPBELL, Alison Margaret | Administrateur | 15 Warriston Crescent EH3 5LA Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 613550001 | |||||||||
| CAMPBELL, Douglas Alexander | Administrateur | (170 Blythswood Court) G2 7PH Glasgow 5 Cadogan Square Scotland | Scotland | British | 164862860001 | |||||||||
| CORR, Bridgid Annia | Administrateur | 12 Hope Street Edinburgh EH2 4DB Midlothian | Welsh | 122016540002 | ||||||||||
| CRAIG, Maxwell Davidson | Administrateur | 9 Kilbryde Crescent FK15 9BA Dunblane Perthshire | British | 48936250001 | ||||||||||
| CRAIG, Sarah | Administrateur | 12 Hope Street Edinburgh EH2 4DB Midlothian | British | 76630400003 | ||||||||||
| DONNELLY, Michael, Professor | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | British | 192300300001 | |||||||||
| EWART, Carole | Administrateur | 0/1 65 Garnet Street G3 6QL Glasgow | Scotland | British | 54206480001 | |||||||||
| FERMIE, Joti Singh | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | British | 249737250001 | |||||||||
| FORBES, Jayne | Administrateur | 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | British | 244608470001 | |||||||||
| FORFAR, Carol | Administrateur | 63 Stewart Clark Avenue EH30 9QJ South Queensferry West Lothian | Scotland | British | 34889790001 | |||||||||
| FRASER, David James | Administrateur | 12 Hope Street Edinburgh EH2 4DB Midlothian | Scotland | British | 99129500001 | |||||||||
| FULTON, Ian | Administrateur | c/o Scottish Refugee Council Floor 6 17 Renfield Street G2 5AH Glasgow Portland House Scotland | Scotland | British | 763110001 | |||||||||
| GAFFNEY, Alix Lesley Crear | Administrateur | 28 Esplanade Terrace EH15 2ES Edinburgh | British | 48936410001 | ||||||||||
| GALBRAITH, Neil Wylie | Administrateur | 21 Courthill Avenue G44 5AA Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 70368050001 | |||||||||
| GARCIA, Eigrrael Salinas | Administrateur | 130/F7 Calton Road EH8 8JQ Edinburgh Midlothian | Colombian | 114605870001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SCOTTISH REFUGEE COUNCIL ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 06 avr. 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0