PROSPECTRE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPROSPECTRE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC145280
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PROSPECTRE LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe PROSPECTRE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 South Gyle Crescent Lane
    EH12 9EG Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PROSPECTRE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HARMONIUM LIMITED02 juil. 199302 juil. 1993

    Quels sont les derniers comptes de PROSPECTRE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour PROSPECTRE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Changement d'adresse du siège social de Media House 60 Maxwell Road Glasgow G41 1PR le 14 sept. 2010

    1 pagesAD01

    legacy

    38 pagesMG01s

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 juil. 2010

    État du capital au 08 juil. 2010

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Cessation de la nomination de Virgin Media Secretaries Limited en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Virgin Media Secretaries Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Virgin Media Directors Limited en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Robert Mario Mackenzie en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Robert Charles Gale en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Gillian Elizabeth James en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Modifications à la charge flottante 10

    42 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante 11

    42 pages466(Scot)

    Qui sont les dirigeants de PROSPECTRE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151396130001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Secrétaire
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Secrétaire
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Secrétaire
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    BURNETT & REID
    15 Golden Square
    AB10 1WF Aberdeen
    Secrétaire
    15 Golden Square
    AB10 1WF Aberdeen
    39027620001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Secrétaire
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Administrateur
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Administrateur
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Administrateur
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    KNAPP, James Barclay
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Administrateur
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Us Citizen79688880001
    LEVIE, David Stuart Craigen
    15 Golden Square
    AB9 1JF Aberdeen
    Administrateur désigné
    15 Golden Square
    AB9 1JF Aberdeen
    British900005070001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Administrateur
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Administrateur
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MCKELLAR, Ronald Alexander
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    British7345780001
    MCLEOD, Allan Macrae
    19 Kings Gate
    AB15 4EL Aberdeen
    Administrateur
    19 Kings Gate
    AB15 4EL Aberdeen
    British35637260002
    OKAS, John Anthony
    Dipley Springs, Dipley Common
    RG27 8JS Hook
    Hampshire
    Administrateur
    Dipley Springs, Dipley Common
    RG27 8JS Hook
    Hampshire
    EnglandBritish112280340001
    RICHTER, Bret
    245 East 63rd Street
    Apartment 20h
    10021 New York
    New York
    United States
    Administrateur
    245 East 63rd Street
    Apartment 20h
    10021 New York
    New York
    United States
    American86830760001
    ROBERTS, Gareth Nigel Christopher
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    Administrateur
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    British145824690001
    ROSS, Stuart
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    Administrateur
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    EnglandBritish20168110001
    SCHUBERT, Scott Elliott
    9 William Street House
    William Street
    SW1X 9HH London
    Administrateur
    9 William Street House
    William Street
    SW1X 9HH London
    American89618040001
    WOOD, Leigh
    The Priory 10 Hambledon Park
    Hambledon
    GU8 4ER Godalming
    Surrey
    Administrateur
    The Priory 10 Hambledon Park
    Hambledon
    GU8 4ER Godalming
    Surrey
    American53880530001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    PROSPECTRE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite debenture
    Créé le 29 juin 2010
    Livré le 09 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 09 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 01 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Confirmation deed
    Créé le 15 avr. 2010
    Livré le 30 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 30 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 30 avr. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Confirmation deed
    Créé le 15 avr. 2010
    Livré le 30 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 30 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 30 avr. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 08 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 08 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Composite debenture
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 02 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 02 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 17 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Composite debenture
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 28 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 28 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 28 janv. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 avr. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 28 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 28 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 28 janv. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 avr. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 16 juin 2006
    Livré le 04 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 04 juil. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 juil. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 16 juin 2006
    Livré le 04 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 04 juil. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 juil. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 03 mars 2006
    Livré le 22 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 22 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 janv. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 03 mars 2006
    Livré le 22 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 22 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 13 avr. 2004
    Livré le 30 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under any or all of the finance documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over assets - see mortgage document for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 30 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 27 sept. 2001
    Livré le 03 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations as contained in the finance documents
    Brèves mentions
    Legal mortgage over land; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited
    Transactions
    • 03 oct. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 21 févr. 2001
    Livré le 06 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations pursuant to the finance documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over assets..see ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Chase Manahattan International Limited
    Transactions
    • 06 mars 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 17 oct. 1997
    Livré le 04 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 04 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0