MANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED

MANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC145369
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED ?

    • (4521) /

    Où se situe MANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Regency House Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Fife
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MELVILLE DUNDAS (BRIDGE OF WEIR) LIMITED25 juil. 200325 juil. 2003
    MANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED20 mars 200220 mars 2002
    MDW LIMITED26 juil. 199326 juil. 1993
    MELVILLE DUNDAS LIMITED12 juil. 199312 juil. 1993

    Quels sont les derniers comptes de MANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour MANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Retrait de la demande de radiation de la société

    2 pagesDS02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital au 21 févr. 2011

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Cessation de la nomination de Norman Yardley en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02s

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Nomination de Norman Yardley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Dominic Lavelle en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de MANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808840001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    FULTON, John Alexander
    7 Old Vinery
    Kippen
    FK8 3JD Stirling
    Stirlingshire
    Secrétaire
    7 Old Vinery
    Kippen
    FK8 3JD Stirling
    Stirlingshire
    British148020001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MILLER, Alasdair James
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    Secrétaire
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    British200739750001
    PARSLIFFE, Andrew John
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    Secrétaire
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    BritishAccountant67033440002
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire désigné
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    BritishSolicitor122926460001
    CONWAY, Peter Michael
    The Green
    Talkin
    CA8 1LT Brampton
    Cumbria
    Administrateur
    The Green
    Talkin
    CA8 1LT Brampton
    Cumbria
    United KingdomBritishConstruction Director156360001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    FULTON, John Alexander
    7 Old Vinery
    Kippen
    FK8 3JD Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    7 Old Vinery
    Kippen
    FK8 3JD Stirling
    Stirlingshire
    BritishDirector148020001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritishCompany Director113081830001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant94163020001
    MCGOWAN, Robert
    139 Hamilton Place
    AB15 5BD Aberdeen
    Administrateur
    139 Hamilton Place
    AB15 5BD Aberdeen
    ScotlandBritishCompany Director64498380002
    PUNLER, Keith Arthur
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    Administrateur
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    ScotlandBritishChartered Surveyor142078700006
    SHEARER, William Wallace
    Brownside Cottage
    Caldermill
    ML10 6QD Strathaven
    Administrateur
    Brownside Cottage
    Caldermill
    ML10 6QD Strathaven
    BritishDirector And Civil Engineer148030001
    YARDLEY, Norman
    Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Sovereign House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Sovereign House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishDirector153904770001

    MANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 08 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 30 déc. 2002
    Livré le 09 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of land comprising 1,241 square metres at windy ridge, torr road, bridge of weir.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 18 janv. 2002
    Livré le 25 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Strip of ground measuring 600 millimeters in width as detailed on plan.
    Personnes ayant droit
    • Melville Dundas Limited
    Transactions
    • 25 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 déc. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 14 janv. 2002
    Livré le 16 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land at torr road, bridge of weir registered under title numbers REN107873 and REN107874.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 févr. 1994
    Livré le 02 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 mars 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0