MORRISON STREET HOTEL LIMITED

MORRISON STREET HOTEL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMORRISON STREET HOTEL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC146403
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MORRISON STREET HOTEL LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe MORRISON STREET HOTEL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MORRISON STREET HOTEL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KANTEL MACDONALD ORR LIMITED21 avr. 199421 avr. 1994
    ORRMAC (NO.320) LIMITED13 sept. 199313 sept. 1993

    Quels sont les derniers comptes de MORRISON STREET HOTEL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour MORRISON STREET HOTEL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    6 pages4.26(Scot)

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    19 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 1 Morrison Street Link Edinburgh EH3 8DN Scotland à Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG le 08 sept. 2017

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 sept. 2017

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Inscription de la charge SC1464030015, créée le 23 mars 2017

    60 pagesMR01

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Période comptable actuelle raccourcie du 28 févr. 2017 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Caledonian Exchange 19a Canning Street Edinburgh EH3 8HE Scotland à 1 Morrison Street Link Edinburgh EH3 8DN le 19 oct. 2016

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de James Alexander Macconnell Orr en tant que directeur le 07 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon John Hobbs en tant que directeur le 07 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Angus Donald Mackintosh Macdonald en tant que directeur le 07 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Patricia Findlay en tant que directeur le 07 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Queensferry Secretaries Limited en tant que secrétaire le 07 oct. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Daniel Roger en tant qu'administrateur le 07 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    1 pagesMR04

    État du capital au 21 sept. 2016

    • Capital: GBP 1,666,666
    4 pagesSH02

    Nomination de Simon John Hobbs en tant qu'administrateur le 07 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nicholas James Brown en tant que directeur le 30 août 2016

    1 pagesTM01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 03 mars 2016

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 mars 2016

    État du capital au 23 mars 2016

    • Capital: GBP 4,150,340
    SH01

    Qui sont les dirigeants de MORRISON STREET HOTEL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROGER, Daniel
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    GermanyGermanCompany Director193480980002
    ORR, Pauline Anne
    Flat 3
    40 Smith Square
    SW1P 3HL London
    Secrétaire
    Flat 3
    40 Smith Square
    SW1P 3HL London
    British52526750007
    ORR MACQUEEN WS
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secrétaire désigné
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    900000160001
    QUEENSFERRY SECRETARIES LIMITED
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    United Kingdom
    Secrétaire
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    United Kingdom
    Forme juridiqueSCOTTISH PRIVATE LIMITED COMPANY
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleLAW OF SCOTLAND
    Numéro d'enregistrementSC145858
    38051430004
    BROWN, Nicholas James
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Administrateur
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    EnglandBritishDirector53219100003
    COOPER, Neil
    14 Paddock Wood
    AL5 1JS Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Paddock Wood
    AL5 1JS Harpenden
    Hertfordshire
    BritishFinance Director95948960002
    COOPER, Neil
    14 Paddock Wood
    AL5 1JS Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Paddock Wood
    AL5 1JS Harpenden
    Hertfordshire
    BritishFinance Director95948960002
    DOOLAN, Andrew Peter
    3 Randolph Lane
    EH1 2LZ Edinburgh
    Administrateur
    3 Randolph Lane
    EH1 2LZ Edinburgh
    BritishArchitect788130006
    ELLIOT, Colin David
    54 Queens Grove
    NW8 6EN London
    Administrateur
    54 Queens Grove
    NW8 6EN London
    BritishFinance Director84492240002
    FINDLAY, Patricia
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Administrateur
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    EnglandBritishCompany Director110058900001
    FLAUM, Paul Charles
    Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    1
    Hertfordshire
    Administrateur
    Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    1
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector97797290002
    FORREST, John Joseph
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Administrateur
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    EnglandBritishDirector204618050002
    GUDKA, Ganesh Harshit Harakhchand
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Administrateur
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    EnglandBritishAccountant177627370001
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Administrateur
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Executive88628480001
    HOBBS, Simon John
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Administrateur
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    EnglandBritishChartered Surveyor213773980001
    KELLOCK, William Nicholas Russell
    2 Trout Hollow
    Saunderton
    HP27 9UA Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 Trout Hollow
    Saunderton
    HP27 9UA Princes Risborough
    Buckinghamshire
    BritishDirector55756030001
    MACDONALD, Angus Donald Mackintosh
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Administrateur
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    ScotlandBritishChartered Accountant43780001
    MCNESTRY, Hugo
    51 Riverview Grove
    Chiswick
    W4 3QL London
    Administrateur
    51 Riverview Grove
    Chiswick
    W4 3QL London
    IrishAccountant100837360001
    NASH, Derek Andrew
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor32051710001
    ORR, James Alexander Macconnell
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Administrateur
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    ScotlandBritishSolicitor81233650001
    ORR, Pauline Anne
    9 Saxe Coburg Street
    EH3 5BN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Saxe Coburg Street
    EH3 5BN Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor52526750005
    PARKER, Alan Charles
    Wayfarers Lake Road
    Wentworth
    GU25 4QW Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Wayfarers Lake Road
    Wentworth
    GU25 4QW Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishDirector36959900001
    PELLINGTON, Andrew David
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Administrateur
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    United KingdomBritishDirector191886610001
    PELLINGTON, Andrew David
    134 Brampton Road
    AL1 4PY St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    134 Brampton Road
    AL1 4PY St Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector104981400001
    WINDLE, Graham
    22 Churchill Road
    AL1 4HQ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    22 Churchill Road
    AL1 4HQ St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant244099870001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MORRISON STREET HOTEL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bath Road
    UB7 0DP West Drayton
    Leonardo Hotel London Heathrow Airport
    United Kingdom
    05 sept. 2016
    Bath Road
    UB7 0DP West Drayton
    Leonardo Hotel London Heathrow Airport
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement10360214
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    MORRISON STREET HOTEL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 mars 2017
    Livré le 07 avr. 2017
    En cours
    Brève description
    First charge in relation to all estates and interests in any freehold, commonhold or leasehold property now or in the future belonging to it, whether arising at law, in equity, or otherwise. For more details of land, ship, aircraft and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    Standard security
    Créé le 04 oct. 2011
    Livré le 13 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area or piece of ground lying to the south west of morrison street edinburgh (1 morrison link) please see form for more details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 19 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 26 sept. 2011
    Livré le 01 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 19 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 27 févr. 2002
    Livré le 05 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond dated 21 april 1999
    Brèves mentions
    Area of ground lying to the east of the new link road known as morrison link between the west approach road and morrison street, edinburgh extending to 72.30 square metres.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 mars 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 25 févr. 2002
    Livré le 27 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond dated 21 april 1999 as varied, amended or supplemented from time to time
    Brèves mentions
    72.30 square metres of ground lying to the east of the new link road known as morrison link between the west approach road and morrison street, edinburghtogether with right, title and interest and free access therto.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 févr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 23 avr. 1999
    Livré le 26 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.359 hectares and 0.337 hectares at morrison street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 avr. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 21 avr. 1999
    Livré le 23 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 avr. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 déc. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 13 juil. 1998
    Livré le 20 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.337 ha between the west approch road & mprrison street,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 nov. 1995
    Livré le 22 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground lying to the south west of morrison street, edinburgh, extending to 0.359 hectares.
    Personnes ayant droit
    • Lothian and Edinburgh Enterprise Limited
    Transactions
    • 22 nov. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 1995
    Livré le 28 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.359 ha to the south west of morrison street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 25 avr. 1995
    Livré le 28 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 mai 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Standard security
    Créé le 23 déc. 1994
    Livré le 10 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.359 ha to the south west of morrison street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Macdonald Orr Limited
    Transactions
    • 10 janv. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 déc. 1994
    Livré le 29 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due and to become due in terms of a personal bond dated 22/12/94
    Brèves mentions
    Area of ground at the south west of morrison street, edinburgh, extending to 0.359 hectares.
    Personnes ayant droit
    • Whitbread PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 22 déc. 1994
    Livré le 10 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macdonald Orr Limited
    Transactions
    • 10 janv. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 janv. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Floating charge
    Créé le 22 déc. 1994
    Livré le 29 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due and to become due, and all obligations ad factum praestandum
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Whitbread PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 janv. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui

    MORRISON STREET HOTEL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 sept. 2017Commencement of winding up
    16 nov. 2018Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0