HUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED

HUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC146570
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED ?

    • (7420) /
    • (7487) /

    Où se situe HUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o ARCHIAL ARCHITECTS LIMITED
    18 Rothesay Place
    EH3 7SQ Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SMC HUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED14 nov. 200614 nov. 2006
    SMC HUGH MARTIN LIMITED29 sept. 200629 sept. 2006
    THE HUGH MARTIN PARTNERSHIP LIMITED21 sept. 199321 sept. 1993

    Quels sont les derniers comptes de HUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Cessation de la nomination de Christopher Littlemore en tant que directeur

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Changement d'adresse du siège social de * 12 Hope Street Edinburgh EH2 4DB* le 26 avr. 2010

    1 pagesAD01

    État du capital au 06 janv. 2010

    • Capital: GBP 70,000
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    21 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    20 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed smc hugh martin architects LIMITED\certificate issued on 15/01/09
    3 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    Qui sont les dirigeants de HUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, John James
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    Secrétaire
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    British138774840001
    BOARDMAN, Robert Philip
    87 Cavendish Road
    SW12 0BN London
    Administrateur
    87 Cavendish Road
    SW12 0BN London
    British77296310006
    TAYLOR, John James
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    Administrateur
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    ScotlandBritish138774840001
    BOARDMAN, Robert Philip
    Ockham Road South
    East Horsley
    KT24 6SL Leatherhead
    Luccombe
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ockham Road South
    East Horsley
    KT24 6SL Leatherhead
    Luccombe
    Surrey
    United Kingdom
    British77296310007
    BOARDMAN, Robert Philip
    81 Mysore Road
    SW11 5RZ London
    Secrétaire
    81 Mysore Road
    SW11 5RZ London
    British77296310002
    GODFREY, Caroline Mary
    38 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    Secrétaire
    38 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    British44441450002
    MCLEISH, Neil Stanley
    5 James Street
    EH15 2DS Edinburgh
    Secrétaire
    5 James Street
    EH15 2DS Edinburgh
    British36158150001
    WILLS, Nicholas Kenneth Spencer
    The Great House
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    The Great House
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    British46198200002
    BROWNING, Christopher George John
    The Croft
    Vantage Farm, Fordell Estate
    KY11 7EY Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    The Croft
    Vantage Farm, Fordell Estate
    KY11 7EY Dunfermline
    Fife
    British119400480001
    CAMPBELL, Ian Stuart
    19 Trinity Grove
    EH5 3HB Edinburgh
    Administrateur
    19 Trinity Grove
    EH5 3HB Edinburgh
    British45195070001
    KEITH, George Mcintosh
    Inverforth 50 Laverockbank Road
    EH5 3BZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Inverforth 50 Laverockbank Road
    EH5 3BZ Edinburgh
    Midlothian
    British254780001
    LITTLEMORE, Christopher Paul
    Meadow House
    High Lane Broad Chalke
    SP5 5HA Salisbury
    Wilts
    Administrateur
    Meadow House
    High Lane Broad Chalke
    SP5 5HA Salisbury
    Wilts
    EnglandBritish20118320001
    MCCOLL, James Stewart
    3 Fulmer Place, Fulmer Road
    Fulmer
    SL3 6HR Slough
    Administrateur
    3 Fulmer Place, Fulmer Road
    Fulmer
    SL3 6HR Slough
    British146976380002
    MCLEISH, Neil Stanley
    5 James Street
    EH15 2DS Edinburgh
    Administrateur
    5 James Street
    EH15 2DS Edinburgh
    ScotlandBritish36158150001
    SCOTT, Donald
    38 Craigmount Bank
    EH4 8HH Edinburgh
    Administrateur
    38 Craigmount Bank
    EH4 8HH Edinburgh
    British36158130001
    SUTHERLAND, Ronald Scott
    Lismhor 11 Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Lismhor 11 Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    Midlothian
    British254760001
    WALKER, David Cameron
    11 Corstorphine Hill Gardens
    EH12 6LB Edinburgh
    Administrateur
    11 Corstorphine Hill Gardens
    EH12 6LB Edinburgh
    United KingdomBritish36158140001

    HUGH MARTIN ARCHITECTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 22 sept. 2006
    Livré le 30 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 22 oct. 1993
    Livré le 01 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    37A drumsheugh gardens, edinburgh and now forming no. 38B drumsheugh gardens, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 oct. 1993
    Livré le 01 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Office premises consisting of ground and first floors and basement forming 37A drumsheugh gardens, edinburgh and now forming 38B drumsheugh gardebs, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Ronald Scott Sutherland
    Transactions
    • 01 nov. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 30 sept. 1993
    Livré le 07 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 30 sept. 1993
    Livré le 06 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 oct. 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 oct. 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0