CATLIN (PUL) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCATLIN (PUL) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC147137
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CATLIN (PUL) LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe CATLIN (PUL) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7 Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CATLIN (PUL) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WELLINGTON (PUL) LIMITED06 oct. 200406 oct. 2004
    PREMIUM UNDERWRITING LIMITED22 oct. 199322 oct. 1993

    Quels sont les derniers comptes de CATLIN (PUL) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour CATLIN (PUL) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    7 pagesLIQ13(Scot)

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN à 7 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8AN le 10 août 2021

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 05 août 2021

    LRESSP

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Declaration of an interim dividend of £3,994 paid on 10 june 2021 to sole member of the company 10/06/2021
    RES13

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Rankin Cummings le 19 mars 2021

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    12 pagesAA

    Nomination de Mr Mark Rankin Cummings en tant qu'administrateur le 18 mai 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Richard Bradbrook en tant que directeur le 18 mai 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Craig Standen en tant qu'administrateur le 17 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Juliet Phillips en tant que directeur le 17 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Paul Andrew Jardine en tant que directeur le 26 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Clynton Jacobus Luttig en tant qu'administrateur le 26 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Miss Juliet Phillips en tant qu'administrateur le 01 août 2016

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mars 2016

    État du capital au 07 mars 2016

    • Capital: GBP 1,848,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de CATLIN (PUL) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REES, Marie Louise
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    7 Exchange Crescent
    Secrétaire
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    7 Exchange Crescent
    201011090001
    CUMMINGS, Mark Rankin
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    7 Exchange Crescent
    Administrateur
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    7 Exchange Crescent
    EnglandBritish254912020002
    LUTTIG, Clynton Jacobus
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    7 Exchange Crescent
    Administrateur
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    7 Exchange Crescent
    EnglandBritish218565170001
    STANDEN, Craig
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    7 Exchange Crescent
    Administrateur
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    7 Exchange Crescent
    United KingdomBritish265497100001
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Secrétaire
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GUYATT, Elizabeth Helen
    Saltire Court
    20 Catle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Secrétaire
    Saltire Court
    20 Catle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British100201680002
    NOONE, Lisa Marie
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    British72182310002
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Secrétaire
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    British70960040001
    THOMAS, Heather Irene
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    Secrétaire
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    British105936240001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire désigné
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900004640001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secrétaire
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    WELLINGTON INSURANCE LIMITED
    88 Leadenhall Street
    EC3A 3BA London
    Secrétaire
    88 Leadenhall Street
    EC3A 3BA London
    100566440001
    AVERY, Julian Ralph
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    Administrateur
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    United KingdomUk37578750001
    BRADBROOK, Paul Richard
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritish148983260001
    BURKE, Martin Thomas
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    United KingdomIrish240344510001
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    CALLAN, Robert
    Saltire Court
    20 Catle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Catle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritish130365420001
    CUSACK, Julian Michael
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    British84410430001
    FRESHWATER, Neil Andrew, Mr.
    Saltire Court
    20 Catle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Catle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    EnglandBritish125646370001
    HARDIE, David
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur désigné
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004620001
    HAYNES, Joseph Antony
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Administrateur
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    British9580170001
    HOOK, Christian Robert Macnachtan
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    British45036950001
    IBESON, David Christopher Ben
    Saltire Court
    20 Catle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Catle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritish52745170002
    IBESON, David Christopher Ben
    The Orchard House
    Beech Avenue, Effingham
    KT24 5PJ Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    The Orchard House
    Beech Avenue, Effingham
    KT24 5PJ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish52745170002
    IVORY, Ian Eric
    Ruthven House
    Ruthven
    PH12 8RF Blairgowrie
    Perthshire
    Administrateur
    Ruthven House
    Ruthven
    PH12 8RF Blairgowrie
    Perthshire
    United KingdomBritish69668870001
    JARDINE, Paul Andrew
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    EnglandBritish62337170003
    JENNER, Michael Eugene
    Moons Farm
    Barcombe Road
    TN22 3XG Piltdown
    East Sussex
    Administrateur
    Moons Farm
    Barcombe Road
    TN22 3XG Piltdown
    East Sussex
    British12441700001
    LETSINGER, Katherine Lee
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    Administrateur
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    EnglandBritish,American54716770009
    NOBLE, Timothy Peter, Sir
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    Administrateur
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    United KingdomBritish685750001
    PADULLI, Luca Rinaldo Contardo, Count
    180 Central Park South
    No 76
    New York 10019
    Usa
    Administrateur
    180 Central Park South
    No 76
    New York 10019
    Usa
    UsaItalian101097660001
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Administrateur
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    British70960040001
    PHILLIPS, Juliet
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritish211555110001
    PREBENSEN, Preben
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    Administrateur
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    United KingdomBritish137567870001
    PRIMER, Daniel Francis
    Saltire Court
    20 Catle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Catle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomAmerican112177980002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CATLIN (PUL) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5562639
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CATLIN (PUL) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 16 juil. 2007
    Livré le 31 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 juil. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    Bond & floating charge
    Créé le 16 juil. 2007
    Livré le 31 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 juil. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    Debenture
    Créé le 11 déc. 2003
    Livré le 20 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 20 déc. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 déc. 2003
    Livré le 20 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 20 déc. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Debenture
    Créé le 24 août 1998
    Livré le 04 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 04 sept. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 24 août 1998
    Livré le 04 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 04 sept. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    CATLIN (PUL) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 oct. 2022Due to be dissolved on
    05 août 2021Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0