SULZER (ABERDEEN) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSULZER (ABERDEEN) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC147952
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SULZER (ABERDEEN) LIMITED ?

    • fabrication d'autres machines à usage spécial n.c.a. (28990) / Industries manufacturières

    Où se situe SULZER (ABERDEEN) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Formartine House Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SULZER (ABERDEEN) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SULZER WOOD LIMITED10 janv. 199410 janv. 1994
    ALLCAST LIMITED09 déc. 199309 déc. 1993

    Quels sont les derniers comptes de SULZER (ABERDEEN) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SULZER (ABERDEEN) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au25 mars 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation08 avr. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au25 mars 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SULZER (ABERDEEN) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de John Rowland Davenport en tant que directeur le 10 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Jonathon Ellis en tant qu'administrateur le 10 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2024

    35 pagesAA

    Nomination de Ms Helen Hanlon en tant qu'administrateur le 21 mai 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Vanessa Jackson en tant qu'administrateur le 21 mai 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ravin Pillay Ramsamy en tant que directeur le 21 mai 2025

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    34 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Holger Hans-Jochen Ruckstuhl en tant que directeur le 20 mars 2024

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    35 pagesAA

    Cessation de la nomination de Philippe Andreas Dewitz en tant que directeur le 23 mai 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    41 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Christian Powles en tant que directeur le 17 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Rowland Davenport en tant qu'administrateur le 17 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    36 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christian Powles le 02 juin 2021

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de . Castle Road Industrial Estate Ellon Aberdeenshire AB41 9RF Scotland à Formartine House Castle Street Castlepark Industrial Estate Ellon AB41 9RF le 19 avr. 2021

    1 pagesAD01

    Cessation de Wood Group Engineering & Operations Support Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 mars 2021

    1 pagesPSC07

    Cessation de la nomination de Iain Angus Jones en tant que secrétaire le 22 mars 2021

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Ravin Pillay Ramsamy en tant qu'administrateur le 22 mars 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Holger Hans-Jochen Ruckstuhl en tant qu'administrateur le 22 mars 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de SULZER (ABERDEEN) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLIS, David Jonathon
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    Administrateur
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    ScotlandBritish285759210001
    HANLON, Helen
    6502 Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WL Birmingham
    6502
    England
    Administrateur
    6502 Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WL Birmingham
    6502
    England
    EnglandBritish336149170001
    JACKSON, Vanessa
    Manor Mill Lane
    LS11 8BR Leeds
    Sulzer (Uk) Holdings
    United Kingdom
    Administrateur
    Manor Mill Lane
    LS11 8BR Leeds
    Sulzer (Uk) Holdings
    United Kingdom
    United KingdomBritish327078770001
    BROWN, Charles Nicholas
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    British36752260001
    BROWN, Robert Muirhead Birnie
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    153996880001
    GOOD, Graham
    22 Gladstone Place
    AB10 6XA Aberdeen
    Secrétaire
    22 Gladstone Place
    AB10 6XA Aberdeen
    British57781370001
    JOHNSON, Ian
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    Secrétaire
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    British102664100004
    JONES, Iain Angus
    Castle Road Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    .
    Aberdeenshire
    Scotland
    Secrétaire
    Castle Road Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    .
    Aberdeenshire
    Scotland
    204011970001
    MIDDLETON, Sandra Elizabeth
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    Secrétaire désigné
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    British900000270001
    WATSON, Christopher Edward Milne
    77 Fountainhall Road
    AB15 4EA Aberdeen
    Secrétaire
    77 Fountainhall Road
    AB15 4EA Aberdeen
    British60315030001
    ANGUS, Grant Rae
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Administrateur
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    ScotlandBritish197743170001
    BAILLIE, David Charles
    Birchbank
    AB51 5JU Burnhervie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Birchbank
    AB51 5JU Burnhervie
    Aberdeenshire
    Great BritainBritish89636000001
    BRADWELL, Garth Jeffrey
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    British66587570001
    BROADLEY, Stuart Richard
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    Administrateur
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    ScotlandBritish96818620001
    CARR, William Hadden
    Collieston Hall
    AB41 8RS Collieston
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Collieston Hall
    AB41 8RS Collieston
    Aberdeenshire
    British100270001
    CRAWFORD, James Duncan
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Administrateur
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    ScotlandBritish169953750001
    DAVENPORT, John Rowland
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    Administrateur
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    EnglandBritish291715640001
    DEWITZ, Philippe Andreas
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    Administrateur
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    SwitzerlandSwiss217097980001
    DICKIE, Graham
    12 Northburn Avenue
    AB15 6AH Aberdeen
    Administrateur
    12 Northburn Avenue
    AB15 6AH Aberdeen
    British121618900001
    DOWLE, Keith
    10 Smithies Lane
    S75 1BH Barnsley
    South Yorkshire
    Administrateur
    10 Smithies Lane
    S75 1BH Barnsley
    South Yorkshire
    United KingdomBritish65271810001
    DRON, Alexander
    Villafield
    Elrick
    AB32 6TJ Westhill
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Villafield
    Elrick
    AB32 6TJ Westhill
    Aberdeenshire
    British63998700002
    EDGAR, William
    3 Cairnie View
    Westhill
    AB32 6NB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    3 Cairnie View
    Westhill
    AB32 6NB Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish109447840001
    GILCHRIST, Thomas Armstrong
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Administrateur
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    ScotlandBritish240837940001
    HALL, Stuart
    Newlyn Huntly Road
    AB34 5HE Aboyne
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Newlyn Huntly Road
    AB34 5HE Aboyne
    Aberdeenshire
    British37727490001
    HODGSON, Andrew
    The Poplars
    Church Lane Averham
    NG23 5RB Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Poplars
    Church Lane Averham
    NG23 5RB Newark
    Nottinghamshire
    British109391270001
    JESSIMAN, Scott
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    Administrateur
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    ScotlandBritish181632620001
    JOHNSTONE, Alan James
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Administrateur
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    ScotlandBritish108475490001
    JONES, Wayne
    4 Highbury Road
    Heaton Chapel
    SK4 5AZ Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    4 Highbury Road
    Heaton Chapel
    SK4 5AZ Stockport
    Cheshire
    British98176940001
    JUKES, Robert Arthur
    46 Springwater Avenue
    Holcombe Brook
    BL0 9TX Bury
    Lancashire
    Administrateur
    46 Springwater Avenue
    Holcombe Brook
    BL0 9TX Bury
    Lancashire
    British41727360001
    LANGLANDS, Allister Gordon
    Craigentoul
    16 Hillhead Road, Bieldside
    AB15 9EJ Aberdeen
    Administrateur
    Craigentoul
    16 Hillhead Road, Bieldside
    AB15 9EJ Aberdeen
    ScotlandBritish34145910003
    LITTLE, John
    6 Riverside Park
    Port Elphinstone
    AB51 3SB Inverurie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    6 Riverside Park
    Port Elphinstone
    AB51 3SB Inverurie
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish106011130001
    MCNIVEN, Alan Ross
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    Administrateur désigné
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    British900000280001
    MURRAY, Iain
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    Administrateur
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    UsaBritish155887240001
    NADKARNI, Subodh Satchitanand
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Sulzer Wood Limited
    Aberdeenshire
    Scotland
    Administrateur
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Sulzer Wood Limited
    Aberdeenshire
    Scotland
    NetherlandsIndian183995950001
    NICOL, Stephen James
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    Administrateur
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    ScotlandBritish162632260012

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SULZER (ABERDEEN) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wood Group Engineering & Operations Support Limited
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    06 avr. 2016
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Oui
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleScotland
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies (Scotland)
    Numéro d'enregistrementSc159149
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Sulzer (Uk) Holdings Limited
    Manor Mill Lane
    LS11 8BR Leeds
    Manor Mill Lane
    West Yorkshire
    England
    06 avr. 2016
    Manor Mill Lane
    LS11 8BR Leeds
    Manor Mill Lane
    West Yorkshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies (England)
    Numéro d'enregistrement03347095
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0