LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED

LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société SC148063
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED ?

    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Citypoint, 65 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    UBERIOR NOMINEES (SWIFT B.P.U.T.) LIMITED10 déc. 199310 déc. 1993

    Quels sont les derniers comptes de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    ACHZY39T

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    6 pagesAA
    XC9NTHDV

    Déclaration de confirmation établie le 23 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XBJX3743

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    6 pagesAA
    ABBQPTIW

    Déclaration de confirmation établie le 23 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XAJY3G7K

    Modification des coordonnées du secrétaire Cbre Global Investors (Uk) Limited le 07 oct. 2021

    1 pagesCH04
    XAFLYE6H

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    6 pagesAA
    AAC4WHGB

    Déclaration de confirmation établie le 23 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X9VHCAOZ

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    6 pagesAA
    A9I6APAX

    Cessation de la nomination de Robert Peter Morgan en tant que directeur le 27 juil. 2020

    1 pagesTM01
    X9AFPC5D

    Nomination de Sadish Kumar en tant qu'administrateur le 08 juil. 2020

    2 pagesAP01
    X99BWW5C

    Déclaration de confirmation établie le 23 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X8KXE1YQ

    Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X8KXCT0B

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA
    S8EPWWLK

    Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7L131S3

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    6 pagesAA
    A7EKB0O9

    Nomination de Mr Robert Peter Morgan en tant qu'administrateur le 30 avr. 2018

    2 pagesAP01
    X75051UJ

    Cessation de la nomination de Michael Christopher Daggett en tant que directeur le 30 avr. 2018

    1 pagesTM01
    X7504WYW

    Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X6L6VW5L

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA
    A6FQ1TB5

    Cessation de la nomination de Jonathan Roderick Dale-Harris en tant que directeur le 30 avr. 2017

    1 pagesTM01
    X65LYM36

    Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X5LRXE0J

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA
    A4Z013XC

    Qui sont les dirigeants de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CBRE INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
    One New Change
    EC4M 9AF London
    Third Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    One New Change
    EC4M 9AF London
    Third Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement1232680
    98655040005
    KUMAR, Sadish
    Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Citypoint, 65
    Administrateur
    Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Citypoint, 65
    United KingdomBritishAccountant271843470001
    MAKELE, Ahmed Remi
    Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Citypoint, 65
    Scotland
    Administrateur
    Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Citypoint, 65
    Scotland
    EnglandBritishReal Estate Fund Management92800810001
    ANDERSON, Richard Alexander
    48 West Square
    SE11 4SP London
    Secrétaire
    48 West Square
    SE11 4SP London
    British44190890002
    ATTLEY, Denise Roberta
    36 Scollon Avenue
    EH19 3QB Bonnyrigg
    Midlothian
    Secrétaire
    36 Scollon Avenue
    EH19 3QB Bonnyrigg
    Midlothian
    British2805770001
    BLACK, Lysanne Jane Warren
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    Secrétaire
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    British46707740002
    BOTHWELL, Karen Margaret
    25 Belford Gardens
    EH4 3EP Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    25 Belford Gardens
    EH4 3EP Edinburgh
    Midlothian
    British34800860001
    BUCHAN, Ozgul Mehmet
    6 Aldergrove Walk
    Airfield Way
    RM12 6NT Hornchurch
    Essex
    Secrétaire
    6 Aldergrove Walk
    Airfield Way
    RM12 6NT Hornchurch
    Essex
    British4489450001
    CAMERON, Helen Joan
    15 Stanley Road
    SM2 6TB Sutton
    Surrey
    Secrétaire
    15 Stanley Road
    SM2 6TB Sutton
    Surrey
    British66097400001
    CAPELLOS, Stella
    56 Runnymede Gardens
    Western Avenue
    UB6 8SU Greenford
    Middlesex
    Secrétaire
    56 Runnymede Gardens
    Western Avenue
    UB6 8SU Greenford
    Middlesex
    British49947490001
    COLE, Stephanie Margaret
    77 Roxy Avenue
    Chadwell Heath
    RM6 4AZ Romford
    Essex
    Secrétaire
    77 Roxy Avenue
    Chadwell Heath
    RM6 4AZ Romford
    Essex
    British37213640001
    DONALD, Carole Ann
    30 Kipling Court
    Greenford Avenue Hanwell
    W7 1LZ London
    Secrétaire
    30 Kipling Court
    Greenford Avenue Hanwell
    W7 1LZ London
    British39357600001
    FARNHAM, Lorraine Susan
    45 Selby Road
    Plaistow
    E13 8NB London
    Secrétaire
    45 Selby Road
    Plaistow
    E13 8NB London
    British46255900003
    FORBES, Arlene
    25 Tollgate Drive
    Stanway
    CO3 5PE Colchester
    Essex
    Secrétaire
    25 Tollgate Drive
    Stanway
    CO3 5PE Colchester
    Essex
    British46196430001
    GALLEY, Marian
    105 Farningham Road
    CR3 6LN Caterham
    Surrey
    England
    Secrétaire
    105 Farningham Road
    CR3 6LN Caterham
    Surrey
    England
    BritishBanker48231490001
    GAY, Gary Mclean
    Gladesdale
    Glenmore Road East
    TN6 1RE Crowborough
    East Sussex
    Secrétaire
    Gladesdale
    Glenmore Road East
    TN6 1RE Crowborough
    East Sussex
    British598780002
    GLANCY, June Wendy
    708 Ferry Road
    EH4 4AH Edinburgh
    Secrétaire
    708 Ferry Road
    EH4 4AH Edinburgh
    British54861480001
    GLENDINNING, Sharron Louise
    22 Bramble Road
    SS9 5HB Leigh On Sea
    Essex
    Secrétaire
    22 Bramble Road
    SS9 5HB Leigh On Sea
    Essex
    British67674210001
    GOLDSMITH, Kim
    23 Lime Court 33 Trinity Close
    E11 4RX London
    Secrétaire
    23 Lime Court 33 Trinity Close
    E11 4RX London
    BritishBanker48234020001
    HARRIS, Ian Robert
    80 Oxlow Lane
    RM9 5XD Dagenham
    Essex
    Secrétaire
    80 Oxlow Lane
    RM9 5XD Dagenham
    Essex
    British46256570001
    HAYWARD, Susan Teresa
    48 Rothbury Avenue
    RM13 9HZ Rainham
    Essex
    Secrétaire
    48 Rothbury Avenue
    RM13 9HZ Rainham
    Essex
    British55056390001
    HENDRY, Laurence John
    33 Chessington Avenue
    DA7 5NN Bexley Heath
    Kent
    Secrétaire
    33 Chessington Avenue
    DA7 5NN Bexley Heath
    Kent
    British598770001
    HENDRY, Laurence John
    33 Chessington Avenue
    DA7 5NN Bexley Heath
    Kent
    Secrétaire
    33 Chessington Avenue
    DA7 5NN Bexley Heath
    Kent
    British598770001
    HUNTER, John Stewart
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    Secrétaire
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    British1127070001
    IMRIE, Steven William
    32 Easter Hermitage
    EH6 8DR Edinburgh
    Secrétaire
    32 Easter Hermitage
    EH6 8DR Edinburgh
    BritishBanker48235790002
    JAMIESON, Irene Margaret
    24 Allanpark Crescnet
    EH14 1LF Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    24 Allanpark Crescnet
    EH14 1LF Edinburgh
    Midlothian
    British110811990001
    JOHNSTON, Allan Farquhar
    6 Folly Pathway
    WD7 8DS Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Folly Pathway
    WD7 8DS Radlett
    Hertfordshire
    British43144320001
    JONES, Arthur Philip Warriner
    Weyhill
    Crown Heights
    GU1 3TX Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Weyhill
    Crown Heights
    GU1 3TX Guildford
    Surrey
    British47070070001
    KING, Thomas Francis Hazell
    61 Beechwood Road
    CR2 0AE South Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    61 Beechwood Road
    CR2 0AE South Croydon
    Surrey
    BritishChartered Surveyor82582620001
    LYALL, James Ross
    7 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    7 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Midlothian
    British64326010001
    MCLEAN, Robin Kean
    7 Bredon Road
    RG41 1HW Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    7 Bredon Road
    RG41 1HW Wokingham
    Berkshire
    British54845850001
    O'HARE, Kevin Patrick
    43 Cromwell Road
    Acton
    W3 6BN London
    Secrétaire
    43 Cromwell Road
    Acton
    W3 6BN London
    British31151870001
    PIERCE, Lesley Anne Frances
    20 Bush Hall Road
    CM12 0PU Billericay
    Essex
    Secrétaire
    20 Bush Hall Road
    CM12 0PU Billericay
    Essex
    British44196070001
    PRYDE, Catherine Joyce
    12 Netherbank
    EH16 6YR Edinburgh
    Secrétaire
    12 Netherbank
    EH16 6YR Edinburgh
    British47717750001
    RAWLINGS, Julie
    2 Herald Walk
    DA1 5SS Dartford
    Kent
    Secrétaire
    2 Herald Walk
    DA1 5SS Dartford
    Kent
    British49946420001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cbre Uk Property Fund (General Partner) Limited
    One New Change
    EC4M 9AF London
    Third Floor
    England
    06 avr. 2016
    One New Change
    EC4M 9AF London
    Third Floor
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House, London
    Numéro d'enregistrement03377515
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 29 sept. 2006
    Livré le 10 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the finance documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Trustee and Agent
    Transactions
    • 10 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 24 mai 1999
    Livré le 25 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    268-282 waterloo road, london.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 24 mai 1999
    Livré le 25 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    14 headgate, colchester.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 24 nov. 1998
    Livré le 08 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    14 headgate,colchester.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 déc. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 24 nov. 1998
    Livré le 08 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    268-282 waterloo road,london.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 déc. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1997
    Livré le 08 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The deferred consideration under an agreement
    Brèves mentions
    The freehold property known as 61 east street taunton as compried in title number ST117541 at hm land registry and the leasehold property known as land and buildings on the north side of colonial way watford comprised in title number HO287263 at hm land registry.
    Personnes ayant droit
    • The Henry Moore Foundation
    Transactions
    • 08 juil. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 08 mars 1995
    Livré le 13 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due and to become due by the governor and company of the bank of scotland
    Brèves mentions
    14 headgate, colchester, essex, registered under title number ex 505255.
    Personnes ayant droit
    • Banque Indosuez
    Transactions
    • 13 mars 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0