S 83 LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéS 83 LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC148181
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de S 83 LTD ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe S 83 LTD ?

    Adresse du siège social
    14 Rutland Square
    Edinburgh
    EH1 2BD Midlothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de S 83 LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    83 SS LTD14 juin 201614 juin 2016
    83 S LTD02 sept. 200802 sept. 2008
    FORT TRADING LIMITED23 déc. 199323 déc. 1993

    Quels sont les derniers comptes de S 83 LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour S 83 LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 mai 2017

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2017 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes modifiés avec exemption totale pour une petite société jusqu'au 31 mai 2016

    6 pagesAAMD

    Déclaration de confirmation établie le 23 déc. 2016 avec mises à jour

    9 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2016

    7 pagesAA

    Satisfaction de la charge SC1481810024 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1481810022 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1481810023 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1481810019 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1481810012 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1481810011 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1481810015 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1481810017 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1481810013 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1481810018 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1481810010 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name14 juin 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Certificat de changement de nom

    Company name changed 83 s LTD\certificate issued on 14/06/16
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name14 juin 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2015 au 31 mai 2016

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 déc. 2015

    État du capital au 23 déc. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Inscription de la charge SC1481810024, créée le 25 mars 2015

    7 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de S 83 LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Victoria Caroline
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    Secrétaire
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    British99461500002
    JONES, Steven Alexander
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    Administrateur
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    United KingdomBritish99461360007
    JONES, Victoria Caroline, Mrs.
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    Administrateur
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    United KingdomBritish160627090001
    HENDERSON, Elaine Catherine
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    Secrétaire
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    British37119590005
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    HENDERSON, Elaine Catherine
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    Administrateur
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    ScotlandBritish37119590005
    JONES, James
    22 Blackford Hill View
    EH9 3HD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    22 Blackford Hill View
    EH9 3HD Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish902280001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur S 83 LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    EH1 2BD Edinburgh
    14 Rutland Square
    Midlothian
    Scotland
    06 avr. 2016
    EH1 2BD Edinburgh
    14 Rutland Square
    Midlothian
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc105694
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Mr Steven Jones
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mrs Victoria Caroline Jones
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    S 83 LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 25 mars 2015
    Livré le 02 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    68 hillhouse road, hamilton - title number LAN153173.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Adam & Company PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 04 févr. 2015
    Livré le 10 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    56 shandwick place, edinburgh. Basement premises of tenement 54 & 56 shandwick place, edinburgh title number MID123979.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Adam & Co PLC
    Transactions
    • 10 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 04 févr. 2015
    Livré le 10 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    11 north bank street, edinburgh. Title number MID157218.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Adam & Company PLC
    Transactions
    • 10 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 21 oct. 2013
    Livré le 25 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects in the city parish of edinburgh and county of midlothian (formerly edinburgh) and known as number seventeen ainslie place, edinburgh being the subjects shown delineated and hatched in red on the plan annexed and signed as relative hereto, together with the common property with all the other feuars of the grounds of drumsheugh, in the pleasure grounds of moray place and ainslie place and the banks behind the same being the subjects in the said parish and county described (firstly) and (secondly) in the disposition by testamentary trustees of mrs bella lindsay or edgecombe in favour of the minister of works dated twentieth and twenty first and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of midlothian (formerly edinburgh) on thirtieth all days of march nineteen hundred and fifty one; together also with the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto, the fittings and fixtures therein and thereon, and the borrower's whole right, title and interest present and future therein and thereto. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Victoria Caroline Jones
    Transactions
    • 25 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 août 2013
    Livré le 20 août 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    6 walker street edinburgh MID143865. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 août 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 août 2013
    Livré le 17 août 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    9 north bank street edinburgh MID131862. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 août 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 août 2013
    Livré le 15 août 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 août 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 juin 2013
    Livré le 21 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the ground floor garage premises known as 101 - 103 rose street north lane, edinburgh forming the ground floor of the building comprising garage premises and workshop premises above known as 101 and 103 rose street north lane, edinburgh, being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID110233. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Victoria Caroline Jones
    Transactions
    • 21 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 27 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 juin 2013
    Livré le 13 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Subjects known as and forming 32 castle street edinburgh. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 04 juin 2013
    Livré le 17 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming numbers 19 and 20 coates crescent, edinburgh and for the purpose of registration of writs, in the county of midlothian comprising (first) the subjects and others known as number 19 coates crescent, edinburgh in the said county with the solum thereof and ground attached thereto being the subjects more particularly described in and disponed by charter by sir patrick walker of coates with consent thereinmentioned in favour of mrs clara miller and another dated 1 march 1822 with instrument of sasine following thereon in favour of mrs clara miller and another dated 18 april 1823 and recorded in the new particular register of sasines, reversions etcetera for the sheriffdoms of edinburgh and haddington, linlithgow and bathgate on 14 may 1823; together with the cellars under the pavement in front, sunk area, back ground and others effeiring thereto; (second) the subjects known as number 20 coates crescent, edinburgh in the said county together with the cellarage under the pavement in front opposite thereto and the whole other parts, privileges and pertinents effeiring thereto, being the subjects more particularly described in and disponed by disposition by the trustees of the honourable james craufurd, lord ardmillan, with consent thereinmentioned in favour of miss margaret wright dated 3 november 1903 and subsequent dates and recorded in the division of the general register of sasines for the county of edinburgh (now midlothian) on 28 november 1903; which said subjects hereinbefore described (first) and (second) are shown delineated in red on the plan annexed and executed as relative hereto; and (third) a one-half pro indiviso share of all and whole that strip of ground attached to the subjects forming and known as number 11 manor place, edinburgh (which strip of ground forms part of the access to the car park constructed on part of inter alia the subjects (first) and (second) hereinbefore described) in the said county being the subjects shown coloured purple on the said plan annexed and executed as relative hereto and being the subjects more particularly described in and disponed by and delineated and coloured red on the plan annexed and signed as relative to disposition by robert williamson gardiner in favour of mccallum advertising limited and the royal institution of chartered surveyors (therein erroneously referred to as "the scottish branch of the royal institution of chartered surveyors") dated 21 february 1966 and recorded in the division of the general register of sasines for the county of midlothian on 23 february 1966; together also with in relation to the subjects (first), (second) and (third) hereinbefore described (one) the heritable and irredeemable servitude rights of wayleave, passage, access, use and others specified and contained in minute of agreement between the drambuie liqueur company limited and the royal institution of chartered surveyors dated 2 june and 31 july 1967 and recorded in the said division of the general register of sasines and also in the books of council & session on 7 august 1967; (two) the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto; (three) the fittings and fixtures therein and thereon; and (four) the borrower's whole right, title and interest, present and future, therein and thereto; excepting always from the subjects hereinbefore described any rights in coates crescent gardens which were conveyed by disposition by the trustees of adam p nimmo and others to the lord provost, magistrates and council of the city of edinburgh recorded in the said division of the general register of sasines on 29 october 1957. notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Victoria Caroline Jones
    Transactions
    • 17 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 04 juin 2013
    Livré le 17 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects forming 8 kew terrace, edinburgh, EH12 5JE being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID53770. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Victoria Caroline Jones
    Transactions
    • 17 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 27 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 mai 2013
    Livré le 07 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 mai 2013
    Livré le 08 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    235 willowbrae road edinburgh see form for details. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 mai 2013
    Livré le 08 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    358 to 362 morning road edinburgh MID68005. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 mai 2013
    Livré le 09 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    6 walker street, edinburgh registered under title number MID143865. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Adam & Company PLC
    Transactions
    • 09 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 avr. 2013
    Livré le 07 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 24 févr. 2009
    Livré le 28 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    4 walker street, edinburgh MID121987.
    Personnes ayant droit
    • Adam & Company PLC
    Transactions
    • 28 févr. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 13 déc. 2007
    Livré le 21 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    235 willowbrae road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Adam & Company PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 nov. 2007
    Livré le 13 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Adam & Company PLC
    Transactions
    • 13 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 19 déc. 1996
    Livré le 31 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    235 willowbrae road,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 déc. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 02 août 1996
    Livré le 07 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 17 mars 1994
    Livré le 22 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Willowbrae service station,235 willowbrae road,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 02 mars 1994
    Livré le 03 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0