BRYANT HOMES SCOTLAND LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BRYANT HOMES SCOTLAND LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC148500 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BRYANT HOMES SCOTLAND LIMITED ?
| Adresse du siège social | Unit C, Ground Floor, Cirrus Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Paisley |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BRYANT HOMES SCOTLAND LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BRYANT HOMES SCOTLAND LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 22 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour BRYANT HOMES SCOTLAND LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Sara Hollowell en tant qu'administrateur le 01 oct. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jennifer Canty en tant que directeur le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Sara Hollowell en tant que secrétaire le 01 oct. 2025 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Jennifer Canty en tant que secrétaire le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 5 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Michael Andrew Lonnon en tant que directeur le 09 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant qu'administrateur le 09 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que secrétaire le 24 avr. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que directeur le 24 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Jennifer Canty en tant qu'administrateur le 24 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Jennifer Canty en tant que secrétaire le 24 avr. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant qu'administrateur le 19 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant que directeur le 19 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 5 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que secrétaire le 27 juin 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant que secrétaire le 27 juin 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de BRYANT HOMES SCOTLAND LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLOWELL, Sara | Secrétaire | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | 340870190001 | |||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 330353690001 | |||||
| HOLLOWELL, Sara | Administrateur | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 200486170001 | |||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | 310643160001 | |||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | British | 175715660001 | ||||||
| CANTY, Jennifer | Secrétaire | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | 322292450001 | |||||||
| CARR, Peter Anthony | Secrétaire | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 165966260001 | |||||||
| DE FEO, Caterina | Secrétaire | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||
| DENNISON, John Patrick Edmund | Secrétaire | 21 Linton Avenue B91 3NN Solihull West Midlands | British | 14008270001 | ||||||
| HASTINGS, Jonathan Philip | Secrétaire | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 219943490001 | |||||||
| JORDAN, James John | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell | Secrétaire désigné | 14 Dalrymple Crescent EH9 2NX Edinburgh | British | 900003350001 | ||||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Administrateur | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | United Kingdom | British | 193735640001 | |||||
| ANDREW, Peter Robert | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| CANTY, Jennifer | Administrateur | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 322288120001 | |||||
| CARNEY, Christopher | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||
| DENNISON, John Patrick Edmund | Administrateur | 21 Linton Avenue B91 3NN Solihull West Midlands | British | 14008270001 | ||||||
| DICKSON, Ian Macdonald | Administrateur | 11 Antonine Road G68 0FE Dullatur Lanarkshire | Scotland | British | 180862450001 | |||||
| FITZGERALD, John Joseph | Administrateur | 15 King Malcolm Close Fairmile Head EH10 7JB Edinburgh | British | 75230530001 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 257671040002 | |||||
| KNIGHT, David Jonathan | Administrateur | 24 Margaret Rose Crescent EH10 7EZ Edinburgh | United Kingdom | British | 190746580001 | |||||
| LONG, William Peter | Administrateur | Vine Cottage Ashwell SG7 5NW Royston Hertfordshire | British | 92829450001 | ||||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34521340004 | |||||
| MACKENZIE, Andrew | Administrateur | Badgers Holt Foxcombe Drive Boars Hill OX1 5DL Oxford | British | 1728940001 | ||||||
| MCDERMOTT, William Walls | Administrateur | 78 Invergarry Drive Deaconsbank G46 8UN Glasgow | British | 74018820001 | ||||||
| MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell | Administrateur désigné | 14 Dalrymple Crescent EH9 2NX Edinburgh | British | 900003350001 | ||||||
| MONKMAN, Robert | Administrateur | 66 Forest Road RH12 4HL Horsham West Sussex | British | 53725340003 | ||||||
| MORRISSEY, Lorraine Rosemary | Administrateur | 11 Heenan Grove WS13 7QJ Lichfield Staffordshire | British | 48558400001 | ||||||
| PHIPPS, Paul David | Administrateur | Purbeck 37 Hammond End SL2 3LG Farnham Common Buckinghamshire | England | British | 5676320001 | |||||
| POTTON, Geoffrey Frederick | Administrateur | Abbotswood Monkmead Lane RH20 2PF West Chiltington West Sussex | British | 60928380003 | ||||||
| SMITH, Nicholas Carey | Administrateur | 107 Meadowspot Morningside EH10 5UY Edinburgh | British | 38140140003 | ||||||
| WHITEMAN, Lynne May | Administrateur | Walnut Tree Cottage Woodside Winkfield SL4 2DP Windsor Berkshire | British | 43553910003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRYANT HOMES SCOTLAND LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant Homes Limited | 06 avr. 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0