ALLIED LONDON & SCOTTISH PROPERTIES PLC

ALLIED LONDON & SCOTTISH PROPERTIES PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALLIED LONDON & SCOTTISH PROPERTIES PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC149066
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALLIED LONDON & SCOTTISH PROPERTIES PLC ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe ALLIED LONDON & SCOTTISH PROPERTIES PLC ?

    Adresse du siège social
    c/o PAM OVER
    Ckd Galbraith Llp
    59 George Street
    EH2 2JG Edinburgh
    Scotland
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALLIED LONDON & SCOTTISH PROPERTIES PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALLIED LONDON & SCOTLAND PROPERTIES LIMITED25 mai 199425 mai 1994
    RANDOTTE (NO. 335) LIMITED15 févr. 199415 févr. 1994

    Quels sont les derniers comptes de ALLIED LONDON & SCOTTISH PROPERTIES PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour ALLIED LONDON & SCOTTISH PROPERTIES PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 févr. 2013

    État du capital au 20 févr. 2013

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Frederick Paul Graham Watson le 20 févr. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Martin Bell en tant que secrétaire le 05 avr. 2012

    1 pagesTM02

    Nomination de Andy Campbell en tant que secrétaire le 05 avr. 2012

    1 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Julian Ingall le 14 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Martin Bell en tant que secrétaire le 13 déc. 2011

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Suresh Premji Gorasia en tant que secrétaire le 13 déc. 2011

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 5th Floor Exchange Crescent Conference Square Edinburgh Lothian EH3 8UL le 15 mars 2011

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Mr Suresh Premji Gorasia en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de John Ashurst en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 27/10/2009
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    9 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2007

    14 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de ALLIED LONDON & SCOTTISH PROPERTIES PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAMPBELL, Andy
    c/o Pam Over
    59 George Street
    EH2 2JG Edinburgh
    Ckd Galbraith Llp
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Pam Over
    59 George Street
    EH2 2JG Edinburgh
    Ckd Galbraith Llp
    Scotland
    Scotland
    168177300001
    GRAHAM WATSON, Frederick Paul
    c/o Pam Over
    59 George Street
    EH2 2JG Edinburgh
    Ckd Galbraith Llp
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    c/o Pam Over
    59 George Street
    EH2 2JG Edinburgh
    Ckd Galbraith Llp
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish80482690001
    INGALL, Michael Julian
    c/o Pam Over
    59 George Street
    EH2 2JG Edinburgh
    Ckd Galbraith Llp
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    c/o Pam Over
    59 George Street
    EH2 2JG Edinburgh
    Ckd Galbraith Llp
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish46465490003
    ASHURST, John Richard
    29 Broadhurst
    KT21 1QB Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    29 Broadhurst
    KT21 1QB Ashtead
    Surrey
    British109128490001
    BELL, Martin
    c/o Pam Over
    59 George Street
    EH2 2JG Edinburgh
    Ckd Galbraith Llp
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Pam Over
    59 George Street
    EH2 2JG Edinburgh
    Ckd Galbraith Llp
    Scotland
    Scotland
    165296730001
    GORASIA, Suresh Premji
    c/o Pam Over
    59 George Street
    EH2 2JG Edinburgh
    Ckd Galbraith Llp
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Pam Over
    59 George Street
    EH2 2JG Edinburgh
    Ckd Galbraith Llp
    Scotland
    Scotland
    155041260001
    MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    Secrétaire désigné
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    British900003350001
    NIXON, John Henry
    40 Portman Square
    W1H 6LT London
    Secrétaire
    40 Portman Square
    W1H 6LT London
    British3390850002
    SHEPHERD & WEDDERBURN
    Saltire Court 20 Castle Terrace
    EH1 2ET Edinburgh
    Secrétaire désigné
    Saltire Court 20 Castle Terrace
    EH1 2ET Edinburgh
    900030690001
    BROWN, Ian Forbes
    8 Ardchoille Park
    Strathmore Street
    PH2 7TL Perth
    Perthshire
    Administrateur
    8 Ardchoille Park
    Strathmore Street
    PH2 7TL Perth
    Perthshire
    British6118720001
    CLAPHAM, Ronald Barrie
    Flat 8/2, 12 Lancefield Quay
    G3 8HR Glasgow
    Administrateur
    Flat 8/2, 12 Lancefield Quay
    G3 8HR Glasgow
    ScotlandBritish101562830001
    LEIGH, Geoffrey Norman, Sir
    38 Belgrave Square
    SW1X 8NT London
    Administrateur
    38 Belgrave Square
    SW1X 8NT London
    British62389840001
    MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    Administrateur désigné
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    British900003350001
    STANTON, Howard Terence
    96 Manor Road
    IG7 5PQ Chigwell
    Essex
    Administrateur
    96 Manor Road
    IG7 5PQ Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish52013920003
    TROTT, Gary Keith
    1 Canterbury Close
    SS6 9PS Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    1 Canterbury Close
    SS6 9PS Rayleigh
    Essex
    United KingdomBritish108358480001
    WHEATLEY, Douglas Gordon George
    Toran M'Or, Garngaber Avenue
    Lenzie,
    G66 4LJ Glasgow
    Administrateur
    Toran M'Or, Garngaber Avenue
    Lenzie,
    G66 4LJ Glasgow
    United KingdomBritish73814720001
    WILL, James Robert
    Myreside
    EH41 4JA Gifford
    East Lothian
    Administrateur désigné
    Myreside
    EH41 4JA Gifford
    East Lothian
    ScotlandBritish900003650001

    ALLIED LONDON & SCOTTISH PROPERTIES PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 25 août 2000
    Acquis le 28 nov. 2001
    Livré le 14 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5TH floor premises at 33 stockwell street, glasgow of the building granite house, trongate, glasgow and osborne street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 14 déc. 2001Enregistrement d'une acquisition (416)
    • 09 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 août 2000
    Livré le 04 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Granite house, glasgow - retail units.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 04 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 août 2000
    Livré le 04 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Granite house, glasgow - offices.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 04 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 août 2000
    Livré le 04 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    New cross shopping centre, hamilton.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 04 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 août 2000
    Livré le 04 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground to south west of houldsworth street, glasgow and to the east of finnieston street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 04 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 04 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Newkirkgate centre, leith, edinburgh (leasehold interest).
    Personnes ayant droit
    • Eurphypo Altiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 04 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 04 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground and property at constitution street & laurie street, edinburgh...see ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 04 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 04 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    36 great junction street, leith, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 04 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 04 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    30 great junction street, leith, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 04 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 04 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    12 great junction street, leith, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 04 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 04 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    6 great junction street, leith, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Eurppaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 04 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 04 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2 great junction street, leith, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 04 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of rents
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 25 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rental income over clydeway centre, finnieston, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank as Agent and Trustee
    Transactions
    • 25 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of rents
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 25 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rental income over granite house,stockwell street, glasgow;newkirkgate centre, leith; 2,6,12,30,36 great junction street, leith & constitution street, leith.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank as Agent and Trustee
    Transactions
    • 25 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of rents
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 25 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rental income over new cross shopping centre,hamilton.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank as Agent and Trustee
    Transactions
    • 25 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 11 août 2000
    Livré le 25 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 25 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 août 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 31 août 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 10 août 2000
    Livré le 31 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiensgesellschaft Europaische Hypothkenbank Der Deutschen Bank as Agent and Trustee
    Transactions
    • 31 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 août 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 31 août 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 07 nov. 1997
    Livré le 19 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Two areas of ground at granite house,stockwell street,175 trongate,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 juin 1996
    Livré le 01 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5.62 acres at bellgrave street, bellshill industrial estate, registered under title number lan 91966.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 juil. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 juin 1996
    Livré le 01 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5.62 acres at bellgrave street, bellshill industrial estate, registered under title number lan 72537.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 juil. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 juin 1996
    Livré le 27 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3998 sq metres to the southwest of houldsworth street, glasgow, registered under title number gla 114563.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juin 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 01 juil. 1994
    Livré le 13 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Granite house, trongate, stockwell street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 01 juil. 1994
    Livré le 13 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Granite house car park, osborne street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 01 juil. 1994
    Livré le 13 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Clydeway industrial centre.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0