ETHOSENERGY (GBR) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéETHOSENERGY (GBR) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC149291
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ETHOSENERGY (GBR) LIMITED ?

    • Réparation de machines (33120) / Industries manufacturières
    • Réparation d'autres équipements (33190) / Industries manufacturières

    Où se situe ETHOSENERGY (GBR) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ethosenergy
    Kirkhill Drive
    AB21 0EU Dyce
    Aberdeen
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ETHOSENERGY (GBR) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WOOD GROUP GAS TURBINE SERVICES LIMITED31 mai 200531 mai 2005
    WOOD GROUP ACCESSORIES & COMPONENTS LIMITED01 juin 200401 juin 2004
    WOOD GROUP COMPONENT REPAIR LIMITED25 janv. 200125 janv. 2001
    WOOD GROUP AERO LIMITED20 déc. 199620 déc. 1996
    JWG 9 LIMITED01 août 199601 août 1996
    DAWSON TURBINES LIMITED31 mai 199431 mai 1994
    CHACAR LIMITED25 févr. 199425 févr. 1994

    Quels sont les derniers comptes de ETHOSENERGY (GBR) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ETHOSENERGY (GBR) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 déc. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 janv. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 déc. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour ETHOSENERGY (GBR) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Statuts

    30 pagesMA
    ADY99ZH6

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    ADY99ZE2

    Inscription de la charge SC1492910003, créée le 06 mars 2025

    17 pagesMR01
    XDY8UME1

    Inscription de la charge SC1492910004, créée le 06 mars 2025

    24 pagesMR01
    XDY920G3

    Modifications à la charge flottante SC1492910002

    18 pages466(Scot)
    ADY9A6JE

    Modifications à la charge flottante SC1492910001

    18 pages466(Scot)
    ADY9A6JM

    Inscription de la charge SC1492910001, créée le 06 mars 2025

    17 pagesMR01
    XDXSXK6B

    Inscription de la charge SC1492910002, créée le 06 mars 2025

    16 pagesMR01
    XDXSYAN5

    Changement d'adresse du siège social de Ethos House Craigshaw Business Park, Craigshaw Road West Tullos Industrial Estate Aberdeen AB12 3QH à Ethosenergy Kirkhill Drive Dyce Aberdeen AB21 0EU le 10 févr. 2025

    1 pagesAD01
    XDW269FE

    Modification des détails de Ethos Energy Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 janv. 2025

    2 pagesPSC05
    XDVU77AJ

    Modification des détails de Ethos Energy Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 févr. 2025

    2 pagesPSC05
    XDVU6KWG

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XDTFQ9H1

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    28 pagesAA
    AD2EG15T

    Modification des détails de Ethos Energy Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov. 2023

    2 pagesPSC05
    XD258YVC

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XCTY6LZ5

    Cessation de la nomination de James Evan Lloyd Davies en tant que directeur le 12 juil. 2023

    1 pagesTM01
    XC7XNROA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    28 pagesAA
    SC48XDPD

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XBV06U5U

    Nomination de Mr James Evan Lloyd Davies en tant qu'administrateur le 05 août 2022

    2 pagesAP01
    XBA5PREO

    Cessation de la nomination de John Campbell Murray en tant que directeur le 05 août 2022

    1 pagesTM01
    XBA5PQE2

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    28 pagesAA
    SB13Z8HK

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XAV0VPM0

    Nomination de Mrs Lorraine Marie Martin en tant qu'administrateur le 16 nov. 2021

    2 pagesAP01
    XAHUA417

    Cessation de la nomination de Amanda Denise Ritchie en tant que directeur le 15 nov. 2021

    1 pagesTM01
    XAHU229C

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    29 pagesAA
    SA8XQY80

    Qui sont les dirigeants de ETHOSENERGY (GBR) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JESSIMAN, Scott
    Kirkhill Drive
    AB21 0EU Dyce
    Ethosenergy
    Aberdeen
    Scotland
    Administrateur
    Kirkhill Drive
    AB21 0EU Dyce
    Ethosenergy
    Aberdeen
    Scotland
    ScotlandBritishDirector181632620001
    MARTIN, Lorraine Marie
    Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    Scotland
    Administrateur
    Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Treasurer289793590001
    O'FLAHERTY, Carole Ann
    Kirkhill Drive
    AB21 0EU Dyce
    Ethosenergy
    Aberdeen
    Scotland
    Administrateur
    Kirkhill Drive
    AB21 0EU Dyce
    Ethosenergy
    Aberdeen
    Scotland
    ScotlandBritishDirector267450270001
    BROWN, Charles Nicholas
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    BritishChartered Secy36752260001
    BROWN, Robert Muirhead Birnie
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Secrétaire
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    153901190001
    GOOD, Graham
    22 Gladstone Place
    AB10 6XA Aberdeen
    Secrétaire
    22 Gladstone Place
    AB10 6XA Aberdeen
    British57781370001
    JOHNSON, Ian
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Secrétaire
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    British102664100004
    MCGREGOR, Alister James
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    Scotland
    Secrétaire
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    Scotland
    187990770001
    SMITH, Devin David
    12 West Park Crescent
    Inverbervie
    DD10 0TX Montrose
    Angus
    Secrétaire
    12 West Park Crescent
    Inverbervie
    DD10 0TX Montrose
    Angus
    BritishCompany Secretary39075850001
    WATSON, Christopher Edward Milne
    77 Fountainhall Road
    AB15 4EA Aberdeen
    Secrétaire
    77 Fountainhall Road
    AB15 4EA Aberdeen
    British60315030001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    AMICARELLA, Ana Burns
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    Administrateur
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    United StatesAmericanDirector267450620001
    ANGUS, Jon
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Administrateur
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    ScotlandBritishDirector27171680003
    BAILLIE, David Charles
    Birchbank
    AB51 5JU Burnhervie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Birchbank
    AB51 5JU Burnhervie
    Aberdeenshire
    Great BritainBritishCompany Director89636000001
    BEST, Alexander
    41d Abercorn Street
    DD4 7FA Dundee
    Angus
    Administrateur
    41d Abercorn Street
    DD4 7FA Dundee
    Angus
    BritishManager66924870001
    BONE, Samuel Stewart Van Dal
    11 Burnhaven Grdns
    Broughty Ferry
    DD5 Dundee
    Angus
    Administrateur
    11 Burnhaven Grdns
    Broughty Ferry
    DD5 Dundee
    Angus
    BritishDirector31750650001
    BRILL-EDWARDS, Harry
    1100 Arcadian Way
    Fortlee
    New Jersey 07024
    Usa
    Administrateur
    1100 Arcadian Way
    Fortlee
    New Jersey 07024
    Usa
    AmericanCompany Director73217080001
    BROWN, Charles Nicholas
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    Administrateur
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    ScotlandBritishChartered Secy36752260001
    BULLIONS, Brian Alexander
    36 Ferndale Drive
    Broughty Ferry
    DD5 3DF Dundee
    Administrateur
    36 Ferndale Drive
    Broughty Ferry
    DD5 3DF Dundee
    Great BritainBritishDirector31750670001
    BURLEY, Thomas
    Flat B3
    Oaklands, Pitheavlis Crescent
    PH2 0JA Perth
    Administrateur
    Flat B3
    Oaklands, Pitheavlis Crescent
    PH2 0JA Perth
    BritishOperations Director66845870002
    CONWAY, Michael
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Administrateur
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    EnglandBritishBusiness Development66845850001
    CROOKS, Colin Rayne
    10 East Caiystane Road
    EH10 6RP Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    10 East Caiystane Road
    EH10 6RP Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritishManaging Director53799080001
    CROSSAN, Finlay George
    42 Bedford Place
    AB2 3NX Aberdeen
    Aberdeenshire
    Scotland
    Administrateur
    42 Bedford Place
    AB2 3NX Aberdeen
    Aberdeenshire
    Scotland
    BritishDirector35503670001
    DALY, Robert
    47 Ruthrieston Court
    Riverside Drive
    AB10 7QF Aberdeen
    Administrateur
    47 Ruthrieston Court
    Riverside Drive
    AB10 7QF Aberdeen
    BritishDirector1298250001
    DAVIES, James Evan Lloyd
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    Administrateur
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    ScotlandBritishVp Facilities And Field Services291654100001
    DOBLER, Mark Stephen
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    Scotland
    Administrateur
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    Scotland
    United StatesAmericanCompany Director158697600001
    DODGSON, John Stewart
    6 Gowanbrae Road
    Bieldside
    AB15 9AQ Aberdeen
    Administrateur
    6 Gowanbrae Road
    Bieldside
    AB15 9AQ Aberdeen
    BritishDirector51403730001
    DUNCAN, Hugh Drummond
    Rivendell
    Netherley
    AB3 2QN Stonehaven
    Administrateur
    Rivendell
    Netherley
    AB3 2QN Stonehaven
    BritishDirector11880730001
    ELDER, Catherine
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    Scotland
    Administrateur
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    Scotland
    ScotlandIrishCompany Director147081540002
    GAUDETTE, George
    20 Saquatucket Bluffs Road
    MA02646 Harwichport
    United States
    Administrateur
    20 Saquatucket Bluffs Road
    MA02646 Harwichport
    United States
    AmericanCompany President64203500001
    HALL, Francis Philip
    North Cardsknoll Rameldry Mill Bank
    Kingskettle
    KY15 7TY Cupar
    Fife
    Administrateur
    North Cardsknoll Rameldry Mill Bank
    Kingskettle
    KY15 7TY Cupar
    Fife
    BritishDirector51403720002
    LANGLANDS, Allister Gordon
    Craigentoul
    16 Hillhead Road, Bieldside
    AB15 9EJ Aberdeen
    Administrateur
    Craigentoul
    16 Hillhead Road, Bieldside
    AB15 9EJ Aberdeen
    ScotlandBritishDeputy Chief Executive34145910003
    MENZIES, Andrew Garland
    14 Edzell Street
    Broughty Ferry
    DD5 3JJ Dundee
    Administrateur
    14 Edzell Street
    Broughty Ferry
    DD5 3JJ Dundee
    BritishCompany Director112884790001
    MOTHERWELL, Thomas
    Durris Stables
    Durris
    AB31 3BD Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Durris Stables
    Durris
    AB31 3BD Banchory
    Kincardineshire
    BritishCompany Director647700002
    MURRAY, John Campbell
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    Administrateur
    Craigshaw Business Park, Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3QH Aberdeen
    Ethos House
    ScotlandBritishDirector272583240001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ETHOSENERGY (GBR) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Kirkhill Drive
    Dyce
    AB21 0EU Aberdeen
    Ethosenergy
    Scotland
    06 avr. 2016
    Kirkhill Drive
    Dyce
    AB21 0EU Aberdeen
    Ethosenergy
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc454431
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ETHOSENERGY (GBR) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 06 mars 2025
    Livré le 13 mars 2025
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust, National Association as Collateral Agent for and on Behalf of the Secured Parties (As Defined in the Instrument)
    Transactions
    • 13 mars 2025Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 06 mars 2025
    Livré le 13 mars 2025
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust, National Association as Collateral Agent for and on Behalf of the Secured Parties (As Defined in the Instrument)
    Transactions
    • 13 mars 2025Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 06 mars 2025
    Livré le 07 mars 2025
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Sumitomo Mitsui Banking Corporation (As Collateral Agent)
    Transactions
    • 07 mars 2025Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 mars 2025Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    A registered charge
    Créé le 06 mars 2025
    Livré le 07 mars 2025
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Sumitomo Mitsui Banking Corporation (As Collateral Agent)
    Transactions
    • 07 mars 2025Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 mars 2025Modification d'une charge flottante (466 Scot)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0