TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED

TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC150058
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TELEWEST SCOTLAND HOLDINGS LIMITED22 avr. 199422 avr. 1994
    RUBYSUDDEN LIMITED07 avr. 199407 avr. 1994

    Quels sont les derniers comptes de TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Nomination de Mr Roderick Gregor Mcneil en tant qu'administrateur le 09 mars 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de William Thomas Castell en tant que directeur le 09 mars 2020

    1 pagesTM01

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    9 pagesLIQ13(Scot)

    Nomination de Mr William Thomas Castell en tant qu'administrateur le 09 sept. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Dominic Dunn en tant que directeur le 09 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 1 South Gyle Crescent Street Edinburgh EH3 8EX

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 1 South Gyle Crescent Street Edinburgh EH3 8EX

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG à Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX le 22 juil. 2019

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 juil. 2019

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 31 août 2018

    • Capital: GBP 1.00
    1 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2017

    17 pagesAA

    legacy

    80 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    legacy

    80 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 03 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    85 pagesPARENT_ACC

    Qui sont les dirigeants de TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMES, Gillian Elizabeth
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Secrétaire
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    151396040001
    HIFZI, Mine Ozkan
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    EnglandBritish182167230001
    MCNEIL, Roderick Gregor
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    EnglandBritish267964620001
    BROADEST, Guy David
    Tile House
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Secrétaire
    Tile House
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    British96454660001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Secrétaire
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Secrétaire
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    WRIGHT, Tina Alison
    7168 S. Niagara Court
    80112 Englewood
    Colorado
    United States Of America
    Secrétaire
    7168 S. Niagara Court
    80112 Englewood
    Colorado
    United States Of America
    British38915690001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Secrétaire
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BRYAN, Danny Frank
    The Marble Suite
    The Mansion Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    Administrateur
    The Marble Suite
    The Mansion Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    American41071470001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Administrateur
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    CARLETON, Lawrence James
    The Marble Suite
    The Mansion,Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    Administrateur
    The Marble Suite
    The Mansion,Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    British38914530001
    CASTELL, William Thomas
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    EnglandBritish248424970001
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Administrateur
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    DAVIDSON, Stephen James
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92784240001
    DUNN, Robert Dominic
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    EnglandBritish179134020002
    GALE, Robert Charles
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    Administrateur
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    EnglandBritish96956740001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Administrateur
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MICHELS, Alan
    Catalina Abbotswood Drive
    St Georges Hill
    KT13 0LT Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Catalina Abbotswood Drive
    St Georges Hill
    KT13 0LT Weybridge
    Surrey
    British43658810001
    REXROTH, Lynn Charles
    St Anton Woodlands Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    St Anton Woodlands Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    American49075080001
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Administrateur
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    Administrateur
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    Administrateur
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    United KingdomBritish164134250001
    VAN VALKENBURG, David Raynor
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Administrateur
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    American53941940001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    Administrateur
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    United KingdomBritish140137570002
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003410001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3291383
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite debenture
    Créé le 29 juin 2010
    Livré le 09 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 09 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Confirmation deed
    Créé le 15 avr. 2010
    Livré le 30 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 30 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 30 avr. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Confirmation deed
    Créé le 15 avr. 2010
    Livré le 30 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 30 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 30 avr. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 08 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 08 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Composite debenture
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 02 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 02 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 17 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Shares pledge
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 29 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right title interest and benefit in pledged securities.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 29 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Composite debenture
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 28 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 28 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 28 janv. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 avr. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 28 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 28 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 28 janv. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 avr. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Shares pledge
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 27 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rights title interest and benefit in pledged securities.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 27 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 01 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 03 mars 2006
    Livré le 22 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 22 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 janv. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 03 mars 2006
    Livré le 22 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 22 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 21 déc. 2004
    Livré le 07 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 07 janv. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 janv. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 21 déc. 2004
    Livré le 07 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 07 janv. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 janv. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 14 juil. 2004
    Livré le 30 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal charges over properties (see mortgage document for full listings); fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 30 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 janv. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 14 juil. 2004
    Livré le 30 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 30 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 janv. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 16 mars 2001
    Livré le 02 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 janv. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 20 mai 1999
    Livré le 01 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 01 juin 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Share pledge agreement
    Créé le 15 mai 1999
    Livré le 01 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Pledged securities as defined in ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 01 juin 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 15 mai 1999
    Livré le 01 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 01 juin 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 sept. 1998
    Livré le 13 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Toronto-Dominion Bank as Security Trustee
    Transactions
    • 13 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 24 juil. 1996
    Livré le 09 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges on various assets....... See ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cibc Wood Gundy PLC as Security Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 09 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 24 juil. 1996
    Livré le 08 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    All property etc....... see ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cibc Wood Gundy PLC as Security Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 08 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 13 juin 1994
    Livré le 27 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge see ch microfiche.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Security Trustee
    Transactions
    • 27 juin 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 13 juin 1994
    Livré le 27 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Security Trustee
    Transactions
    • 27 juin 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 juil. 2019Commencement of winding up
    10 mai 2020Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0