MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED

MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC151333
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED ?

    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Rutland Court
    Edinburgh
    EH3 8EY
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KENMORE NORTHERN LIMITED15 juin 199515 juin 1995
    KENMORE (NEWCASTLE) LIMITED08 juil. 199408 juil. 1994
    JADEDELL LIMITED09 juin 199409 juin 1994

    Quels sont les derniers comptes de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 juil. 2013

    État du capital au 18 juil. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2012

    7 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Mark Whitworth le 09 mai 2011

    2 pagesCH01

    Nomination de Dr Mark Whitworth en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alan Barr en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2010

    8 pagesAA

    Nomination de Mr Thomas Eardley Allison en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Baxter en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2009

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen Roy Baxter le 25 nov. 2009

    3 pagesCH01

    Nomination de Caroline Ruth Marrison Gill en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de William Bowley en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    Comptes établis au 31 juil. 2008

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARRISON GILL, Caroline Ruth
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Secrétaire
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    British147011370001
    ALLISON, Thomas Eardley
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Scotland
    United Kingdom
    Administrateur
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Scotland
    United Kingdom
    ScotlandBritish1037730004
    WHITTAKER, John
    Billown Mansion House
    Malew
    IM9 3DL Ballasalla
    Isle Of Man
    Administrateur
    Billown Mansion House
    Malew
    IM9 3DL Ballasalla
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish1614010001
    WHITWORTH, Mark
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish120679580002
    BOWLEY, William John
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    British4171240002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Secrétaire
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    CHIENE & TAIT
    61 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Secrétaire
    61 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    99191230001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    ALLISON, Thomas Eardley
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    Administrateur
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    ScotlandBritish1037730004
    BARR, Alan Andrew
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    ScotlandBritish121452150001
    BAXTER, Stephen Roy
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    Administrateur
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    ScotlandBritish86622660005
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Administrateur
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritish462890002
    FINDLAY, Alastair Ian
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish30045540003
    GREEN, David Simon
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    Administrateur
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    British42038120003
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    KENNEDY, Patricia Alice
    Newhall
    EH26 9LY Carlops
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    Newhall
    EH26 9LY Carlops
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish168440970002
    KENNEDY, Patricia Alice
    Hazlieburn
    EH46 7AS West Linton
    Peeblesshire
    Administrateur
    Hazlieburn
    EH46 7AS West Linton
    Peeblesshire
    British224880001
    SCOTT, Peter Anthony
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    British1674500002
    THOMSON, William George Ritchie
    6 Oswald Road
    EH9 2HF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    6 Oswald Road
    EH9 2HF Edinburgh
    Midlothian
    British72331280001
    WHARTON, Kenneth John
    Cornercroft
    7 Glendyke Road
    L18 6JR Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Cornercroft
    7 Glendyke Road
    L18 6JR Liverpool
    Merseyside
    British9964160002
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish110163980001
    WILLIAMS, Thomas David
    23 Woodlands Road
    L37 2JN Formby
    Merseyside
    Administrateur
    23 Woodlands Road
    L37 2JN Formby
    Merseyside
    British51662010001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 28 févr. 2007
    Livré le 08 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage, fixed charges, assignments and floating charge - see form 410 paper apart for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 févr. 2007
    Livré le 08 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 16 avr. 1999
    Livré le 21 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 25, whistleberry road, whistleberry industrial estate, hamilton.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 avr. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 15 août 1995
    Livré le 21 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Floating charge on all assets and fixed charge over property at commercial street, rothwell, leeds, registered under title number wyk 103921.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 août 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 01 juin 1995
    Livré le 16 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0