ECTOPHARMA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéECTOPHARMA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC151763
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ECTOPHARMA LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (20590) / Industries manufacturières

    Où se situe ECTOPHARMA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o PINSENT MASONS LLP
    Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ECTOPHARMA LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SAFEDIP LTD.01 juil. 199401 juil. 1994

    Quels sont les derniers comptes de ECTOPHARMA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour ECTOPHARMA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2019 sans mise à jour

    2 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 juil. 2019

    3 pagesAA

    Comptes de micro-entité établis au 31 juil. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2018 avec mises à jour

    14 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 juil. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2017 avec mises à jour

    8 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2016

    5 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2016 avec mises à jour

    9 pagesCS01

    Période comptable précédente raccourcie du 29 juil. 2016 au 28 juil. 2016

    1 pagesAA01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 juil. 2015 au 29 juil. 2015

    1 pagesAA01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 juil. 2015 au 30 juil. 2015

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Patrick Alexander Campbell Fraser en tant que directeur le 11 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    16 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 sept. 2015

    État du capital au 28 sept. 2015

    • Capital: GBP 147,121.07
    SH01

    Nomination de Andrew Christopher Dickson en tant qu'administrateur le 05 août 2015

    3 pagesAP01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 juil. 2014

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alison Spaull en tant que directeur le 05 juin 2015

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Alan Keith Walker en tant que directeur le 31 déc. 2014

    2 pagesTM01

    Nomination de Dr Alison Spaull en tant qu'administrateur le 27 mai 2014

    3 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de ECTOPHARMA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MD SECRETARIES LIMITED
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    C/O Mcgrigors Llp
    Secrétaire
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    C/O Mcgrigors Llp
    117456920001
    BENSON, Matthew James
    c/o Pinsent Masons Llp
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Princes Exchange
    Administrateur
    c/o Pinsent Masons Llp
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Princes Exchange
    British30332650004
    DICK, Robert Ian
    c/o Pinsent Masons Llp
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Princes Exchange
    Administrateur
    c/o Pinsent Masons Llp
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Princes Exchange
    British109407370001
    DICKSON, Andrew Christopher
    10 Priory Grove
    SW8 2PH London
    Flat 40, Priory Grove School
    England
    Administrateur
    10 Priory Grove
    SW8 2PH London
    Flat 40, Priory Grove School
    England
    United KingdomBritish94226760001
    DUFF, Iain
    Wayside Cottage
    Stenton
    EH42 1TE Dunbar
    East Lothian
    Secrétaire
    Wayside Cottage
    Stenton
    EH42 1TE Dunbar
    East Lothian
    British45904600001
    MUIR-SIMPSON, Richard Mannington
    Redmarley
    Kippen
    FK8 3HS Stirling
    Stirlingshire
    Secrétaire
    Redmarley
    Kippen
    FK8 3HS Stirling
    Stirlingshire
    British18958890001
    PARSONS, Ian Stanley
    Newmains
    Stenton
    EH42 1TQ Dunbar
    East Lothian
    Secrétaire
    Newmains
    Stenton
    EH42 1TQ Dunbar
    East Lothian
    British39940860001
    REID, Brian
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    British900007130001
    MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Secrétaire
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    42680350001
    WJM SECRETARIES LIMITED
    302 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Secrétaire
    302 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    79915470001
    CAMPBELL, John
    1905 Mulsanne Dr
    Zionsville
    Indiana 46077
    Usa
    Administrateur
    1905 Mulsanne Dr
    Zionsville
    Indiana 46077
    Usa
    American78498270001
    CAMPBELL FRASER, Patrick Alexander
    c/o Pinsent Masons Llp
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Princes Exchange
    Administrateur
    c/o Pinsent Masons Llp
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Princes Exchange
    ScotlandBritish49441240001
    CARVER, Andrew Stuart
    3a Cathlaw Lane
    EH48 4NN Torphichen
    West Lothian
    Administrateur
    3a Cathlaw Lane
    EH48 4NN Torphichen
    West Lothian
    ScotlandBritish278066520001
    DICKSON, Donald
    Johnscleugh
    Cranshaws
    TD11 3SW Duns
    Berwickshire
    Administrateur
    Johnscleugh
    Cranshaws
    TD11 3SW Duns
    Berwickshire
    British39940880001
    HYDE, David
    Powdrake Farm
    By Airth
    FK2 8SF Falkirk
    Administrateur
    Powdrake Farm
    By Airth
    FK2 8SF Falkirk
    British1028180001
    JACOBS, Walter William, Dr
    1 Stennis Gardens
    Liberton
    EH17 7QW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    1 Stennis Gardens
    Liberton
    EH17 7QW Edinburgh
    Midlothian
    British19307300002
    LEWIS, Alexander David, Dr
    13 Netherbank
    EH16 6YR Edinburgh
    Lewis Healthcare Limited
    Scotland
    Administrateur
    13 Netherbank
    EH16 6YR Edinburgh
    Lewis Healthcare Limited
    Scotland
    ScotlandBritish158373210001
    MABBOTT, Stephen
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Administrateur désigné
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish900008380001
    MCSWAN, Malcolm
    Latch House
    Abernyte
    PH14 9SU Perth
    Perthshire
    Administrateur
    Latch House
    Abernyte
    PH14 9SU Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish108155240001
    MUIR-SIMPSON, Richard Mannington
    Redmarley
    Kippen
    FK8 3HS Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    Redmarley
    Kippen
    FK8 3HS Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritish18958890001
    NICOLSON, Donald Magnus
    25 Millbrae
    Gargunnock
    FK8 3BB Stirlingshire
    Administrateur
    25 Millbrae
    Gargunnock
    FK8 3BB Stirlingshire
    British85094920001
    PARSONS, Ian Stanley
    13 Abbotsford Crescent
    EH10 5DY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    13 Abbotsford Crescent
    EH10 5DY Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish39940860003
    SPAULL, Alison, Dr
    c/o Pinsent Masons Llp
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Princes Exchange
    Administrateur
    c/o Pinsent Masons Llp
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Princes Exchange
    UkBritish190358730001
    WALKER, Alan Keith
    c/o Pinsent Masons Llp
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Princes Exchange
    Administrateur
    c/o Pinsent Masons Llp
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Princes Exchange
    ScotlandBritish90411190001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour ECTOPHARMA LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    01 juil. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    ECTOPHARMA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 31 juil. 2013
    Livré le 08 août 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lochside (International) LTD & Others
    • Robin and Jane Benson
    • Gareth Baird
    • Kate Chetwood
    Transactions
    • 08 août 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Floating charge
    Créé le 19 déc. 2012
    Livré le 08 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 04 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 30 juil. 2010
    Livré le 11 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Matthew J Benson & Others
    Transactions
    • 11 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 07 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0