CONNOISSEURS SCOTLAND
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CONNOISSEURS SCOTLAND |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | SC152243 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CONNOISSEURS SCOTLAND ?
| Adresse du siège social | 1 George Square Castle Brae KY11 8QF Dunfermline Fife |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CONNOISSEURS SCOTLAND ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CONNOISSEURS SCOTLAND ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 avr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 20 avr. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 avr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CONNOISSEURS SCOTLAND ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2024 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 avr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2023 | 7 pages | AA | ||
Nomination de Mr James Thomson en tant qu'administrateur le 10 août 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Tristan Nesbitt en tant que directeur le 10 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Carl Fredrik Laseen en tant qu'administrateur le 24 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022 | 7 pages | AA | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 août 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020 | 7 pages | AA | ||
Nomination de Mr Tristan Nesbitt en tant qu'administrateur le 01 nov. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019 | 7 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Helen Mcbride en tant que directeur le 19 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Michael Andrews en tant que directeur le 12 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Patrick Victor Elsmie en tant que directeur le 26 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Patrick Victor Elsmie en tant qu'administrateur le 01 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr David John Ibbotson en tant qu'administrateur le 01 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Daniel Oliver Rose-Bristow en tant qu'administrateur le 01 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Conor O'leary en tant que directeur le 10 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de CONNOISSEURS SCOTLAND ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBBOTSON, David John | Administrateur | Portpatrick DG9 9AD Stranraer Knockinaam Lodge Dumfries & Galloway Scotland | United Kingdom | British | 183700740001 | |||||||||
| LASEEN, Carl Fredrik | Administrateur | Lanark Road EH14 5DH Juniper Green 486 Edinburgh Scotland | Scotland | Swedish | 318539510001 | |||||||||
| ROSE-BRISTOW, Daniel Oliver | Administrateur | Annat IV22 2EY By Achnasheen The Torridon Hotel Inverness Scotland | Scotland | British | 248489220001 | |||||||||
| RYAN, Frances Julia | Administrateur | Crinan PA31 8SR Lochgilphead Crinan Hotel Scotland | Scotland | British | 223633650001 | |||||||||
| THOMSON, James | Administrateur | Priestfield Road EH16 5UT Edinburgh Prestonfield House, Scotland | Scotland | British | 326322660001 | |||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secrétaire désigné | Castle Brae KY11 8QF Dunfermline 151 Fife Great Britain |
| 900003400001 | ||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secrétaire désigné | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||||||
| YOUNG AND PARTNERS | Secrétaire | George Square Castle Brae KY11 8QF Dunfermline 1 Fife Scotland |
| 176969620001 | ||||||||||
| ANDREWS, Michael Patrick | Administrateur | Scarlett Park Wallyford EH21 8BY Musselburgh 1 Scarlett Park Midlothian Scotland | Scotland | British | 203290000001 | |||||||||
| CARTER, Stephen John | Administrateur | 18 South Feus KY8 6EQ Upper Largo Largo Cottage Fife Scotland | Scotland | British | 290142970001 | |||||||||
| CLAVE, Marianne | Administrateur | 92 Dowanhill St G12 9EG Glasgow 2/1 Strathclyde Scotland | British | British | 177264360001 | |||||||||
| COUPE, Stephen Edward | Administrateur | 34 Cavalry Park Drive EH15 3QG Edinburgh Lothian | British | 39916780001 | ||||||||||
| CRAWFORD, Guy Lindsay | Administrateur | 1 Laverockbank Road EH5 3DG Edinburgh | British | 39916500001 | ||||||||||
| CROME, Peter | Administrateur | 3 Kinnesburn Garden KY16 9HA St Andrews Fife | Scotland | British | 34572350001 | |||||||||
| ELSMIE, Patrick Victor | Administrateur | Auchterarder PH3 1PP Auchterarder Upper Cloan Lodge Scotland | Scotland | British | 259296830001 | |||||||||
| ELSMIE, Patrick Victor | Administrateur | Fairfield Montrose Road PH3 1BZ Auchterarder Perthshire | United Kingdom | British | 41201430001 | |||||||||
| ELSMIE, Patrick Victor | Administrateur | Fairfield Montrose Road PH3 1BZ Auchterarder Perthshire | United Kingdom | British | 41201430001 | |||||||||
| LEDERER, Peter Julian | Administrateur | Ochil Lodge Gleneagles Hotel PH3 1NE Auchterarder Perthshire | Scotland | Canadian/Uk | 570500001 | |||||||||
| LIGNE, Jacques | Administrateur | The Balmoral Hotel Princes Street EH2 2EQ Edinburgh | British | 44722170001 | ||||||||||
| MCBRIDE, Helen | Administrateur | Old Course Hotel KY16 9SP St. Andrews Old Course Hotel Fife Scotland | Scotland | British | 248218590001 | |||||||||
| MCCORKELL, Stephen | Administrateur | 1 Devonshire Gardens G12 0UX Glasgow Strathclyde | British | 103978270001 | ||||||||||
| MCCULLOCH, Kenneth Wilfred | Administrateur | 69 Kelvin Court G12 0AG Glasgow | Scotland | British | 37947170001 | |||||||||
| MILLAR, Kenneth John | Administrateur | 1 Arnprior Place KA7 4PT Ayr Ayrshire | British | 67848830001 | ||||||||||
| MURPHY, Bernard James | Administrateur | 22 Alpin Drive FK15 0FQ Dunblane Perthshire | Scotland | British | 125507730001 | |||||||||
| NESBITT, Tristan | Administrateur | 1 Festival Square EH3 9SR Edinburgh The Sheraton Hotel Scotland | Scotland | British | 276219320001 | |||||||||
| O'LEARY, Conor | Administrateur | Gleneagles Hotel PH3 1NF Auchterarder Gleneagles Hotel Perthshire Scotland | United Kingdom | Irish | 244730670001 | |||||||||
| OVERTON, Andrew Michael | Administrateur | 17 Limefield Avenue WA13 0QB Lymm Cheshire | United Kingdom | British | 103062630001 | |||||||||
| PATON, Craig William | Administrateur | Devonshire Gardens G12 0UX Glasgow 1 Scotland | Scotland | British | 190474650001 | |||||||||
| PEREIRA, Antonio Daniel Antunes | Administrateur | South Gayfield Lane EH1 3NE Edinburgh 5 Scotland | Scotland | Portugese | 178543010001 | |||||||||
| PHELAN, Andrew | Administrateur | C/O Old Course Hotel KY16 9SP St. Andrews Fife | Irish | 66676190001 | ||||||||||
| PORCIANI, Ralph | Administrateur | Maidens Road Turnberry KA26 9LT Girvan Trump Turnberry Ayrshire Scotland | Scotland | British | 190500490001 | |||||||||
| ROGER, Andrew | Administrateur | George Square Castle Brae KY11 8QF Dunfermline 1 Fife Scotland | Great Britain | British | 163451240001 | |||||||||
| ROUSE, Christopher John | Administrateur | Lands Of Tunberry House Turnberry Hotel KA26 9LT Turnberry Ayrshire | British | 57498350001 | ||||||||||
| RYAN, Nicholas Alan | Administrateur | The Cottage PA31 8SR Crinan Argyll | Scotland | British | 530500001 | |||||||||
| SANDERSON, Garry Paul | Administrateur | 9 Whitelea Crescent PA13 4JP Kilmacolm Renfrewshire | Scotland | British | 105939450001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CONNOISSEURS SCOTLAND ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mrs Dorothy Margaret Welsh | 01 août 2018 | Perth Road FK15 0HD Dunblane Iona Perthshire United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Jeremy Francis Hawkings | 07 avr. 2016 | George Square Castle Brae KY11 8QF Dunfermline 1 Fife | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0