R.B.S. PROPERTY (GREENOCK) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | R.B.S. PROPERTY (GREENOCK) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC152246 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe R.B.S. PROPERTY (GREENOCK) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 24/25 St Andrew Square Edinburgh EH2 1AF |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de R.B.S. PROPERTY (GREENOCK) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour R.B.S. PROPERTY (GREENOCK) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Natwest Markets Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 30 sept. 2019 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Nomination de Kristofer Davies en tant qu'administrateur le 20 sept. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sally Jane Sutherland en tant que directeur le 20 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2019 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 14 pages | AA | ||||||||||
Notification de Natwest Markets Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2018 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 août 2018 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Gary Moore en tant qu'administrateur le 01 juin 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew James Nicholson en tant que directeur le 31 mai 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 12 févr. 2018 | 2 pages | PSC09 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 août 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de The Royal Bank of Scotland Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 4 pages | PSC02 | ||||||||||
Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 déc. 2016 | 8 pages | AAMD | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 août 2016 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de R.B.S. PROPERTY (GREENOCK) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST MARKETS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England |
| 249447430001 | ||||||||||
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| DAVIES, Kristofer | Administrateur | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 | England | British | 258155490001 | |||||||||
| MOORE, Gary | Administrateur | Business House G, PO BOX 1000 EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn | Scotland | British | 247794910001 | |||||||||
| ESSLEMONT, Deborah Susan | Secrétaire | 3 Tapitlaw Grove Comrie KY12 9XE Dunfermline Fife | British | 72983900005 | ||||||||||
| MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Secrétaire | 33 Badger Walk EH52 5TW Broxburn West Lothian | British | 40027890002 | ||||||||||
| MILLS, Alan Ewing | Secrétaire | Sheriffs Park EH49 7SR Linlithgow 87 West Lothian | British | 1268780001 | ||||||||||
| RUSSELL, Christine Anne | Secrétaire | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 164005290001 | |||||||||||
| WOOD, Yvonne | Secrétaire | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | British | 114619990001 | ||||||||||
| BEATTIE, Robert Henry | Administrateur | 10 Swanston Green EH10 7EW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 27224590001 | |||||||||
| CAMPBELL, Hew | Administrateur | Yett Holm Woodhall Road, Braidwood ML8 5NF Carluke | Scotland | British | 1416100014 | |||||||||
| CARTLEDGE, David Edmund | Administrateur | Raines Lodge Greenway CM13 2NR Brentwood Essex | British | 38897330001 | ||||||||||
| CHRISPIN, Simon Jonathan | Administrateur | 86 High Street Sandridge AL4 9BZ St Albans Hertfordshire | British | 62029940001 | ||||||||||
| CRIPPS, Anthony Malcolm | Administrateur | 7 Hurlingham Road DA7 5PE Bexleyheath Kent | British | 51826200001 | ||||||||||
| MACARTHUR, Neil Clark | Administrateur | Rbs Gogarburn EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | United Kingdom | British | 81529340002 | |||||||||
| MCKEAN, Alan Wallace | Administrateur | 29 Woodhall Bank EH13 0HL Edinburgh | British | 1019950005 | ||||||||||
| MCKEAN, Alan Wallace | Administrateur | 141 Colinton Road EH14 1BG Edinburgh | British | 1019950002 | ||||||||||
| MILLEN, Aylmer Edwin | Administrateur | Flat 5 30 Eyre Crescent EH3 5EU Edinburgh | British | 40522500001 | ||||||||||
| MILLER, Elspeth Barbara Ann | Administrateur | 17 Falcon Road West EH10 4AD Edinburgh | British | 1029030001 | ||||||||||
| MILLS, Alan Ewing | Administrateur | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | 1268780001 | |||||||||
| NICHOLSON, Andrew James | Administrateur | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | 163664680002 | |||||||||
| SACH, Derek Stephen | Administrateur | Warren Lodge 32 Leigh Hill Road KT11 2HZ Cobham Surrey | British | 646390001 | ||||||||||
| SACH, Derek Stephen | Administrateur | Warren Lodge 32 Leigh Hill Road KT11 2HZ Cobham Surrey | British | 646390001 | ||||||||||
| SHEAVILLS, Ernest Michael | Administrateur | Coombe House, 8 Westgarth Avenue Colinton EH13 0BD Edinburgh | British | 34817880001 | ||||||||||
| SKELDON, Walter Ainslie | Administrateur | 7 Charteris Court EH32 0NU Longniddry East Lothian | Uk | British | 1355620001 | |||||||||
| SPEIRS, Robert | Administrateur | 17 Kings Crescent G84 7RB Helensburgh Dunbartonshire | British | 2592770003 | ||||||||||
| STEWART, Gary Robert Mcneilly | Administrateur | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | 128173150002 | |||||||||
| SUTHERLAND, Sally Jane | Administrateur | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | 166757310001 | |||||||||
| TAYLOR, Aileen Norma | Administrateur | 1 Drumcoile FK15 9LG Braco Perthshire | Scotland | British | 72705110003 | |||||||||
| TOUGH, Eric George William | Administrateur | 4 Doune Terrace EH3 6DY Edinburgh | British | 54132470001 | ||||||||||
| WALLACE, Barbara Charlotte | Administrateur | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | 150055310001 | |||||||||
| WHITEHEAD, Grahame Taylor | Administrateur | Southlea 20 Cammo Crescent EH4 8DZ Edinburgh | British | 1363570003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur R.B.S. PROPERTY (GREENOCK) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Royal Bank Of Scotland Plc | 06 avr. 2016 | St. Andrew Square EH2 2YB Edinburgh 36 Midlothian Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Natwest Markets Plc | 06 avr. 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour R.B.S. PROPERTY (GREENOCK) LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 03 août 2016 | 29 juil. 2016 | La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0