SURFACE CONTROL (GLASGOW) LIMITED

SURFACE CONTROL (GLASGOW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSURFACE CONTROL (GLASGOW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC153259
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SURFACE CONTROL (GLASGOW) LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe SURFACE CONTROL (GLASGOW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    56 Palmerston Place
    EH12 5AY Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SURFACE CONTROL (GLASGOW) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MAINTOWN LIMITED27 sept. 199427 sept. 1994

    Quels sont les derniers comptes de SURFACE CONTROL (GLASGOW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour SURFACE CONTROL (GLASGOW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de réunion finale des créanciers

    3 pages4.17(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * 1 Spitfire Way Grangemouth FK3 9UB* le 03 mars 2011

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    1 pagesCO4.2(Scot)

    Avis de liquidation

    1 pages4.2(Scot)

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2008

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 nov. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 nov. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 nov. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    7 pages363s

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 nov. 2004

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    5 pages410(Scot)

    legacy

    11 pages410(Scot)

    Qui sont les dirigeants de SURFACE CONTROL (GLASGOW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    1924 NOMINEES LIMITED
    Queen Street
    EH2 1JX Edinburgh
    37
    Midlothian
    Secrétaire
    Queen Street
    EH2 1JX Edinburgh
    37
    Midlothian
    137393220001
    GLEESON, Tom
    Ballyhea
    Charleville
    Gurrane
    Cork
    Ireland
    Administrateur
    Ballyhea
    Charleville
    Gurrane
    Cork
    Ireland
    IrelandIrish137305640001
    HANLEY, Noel Patrick
    Glenhaven
    Smiths Road
    Charleville
    28
    Cork
    Ireland
    Administrateur
    Glenhaven
    Smiths Road
    Charleville
    28
    Cork
    Ireland
    IrelandIrish153696330001
    MCGREGOR, Ian Scott
    38 St Vincent Crescent
    G3 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    38 St Vincent Crescent
    G3 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    British2640110001
    MURPHY, Michael
    Sommerville Ballygroman
    Kilumney
    IRISH Ovens
    County Cork
    Ireland
    Secrétaire
    Sommerville Ballygroman
    Kilumney
    IRISH Ovens
    County Cork
    Ireland
    Irish66958110003
    REID, Brian
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    British900007130001
    SNOWIE, Euan Fenwick
    Boquhan House
    Kippen
    Stirlingshire
    Secrétaire
    Boquhan House
    Kippen
    Stirlingshire
    Scottish152234940002
    FITZGERALD, Richard
    Rose Lodge
    Black Rock Road
    IRISH Cork
    Ireland
    Administrateur
    Rose Lodge
    Black Rock Road
    IRISH Cork
    Ireland
    IrelandIrish63501420001
    MABBOTT, Stephen
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur désigné
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Strathclyde
    British900007110001
    MURPHY, Michael
    Sommerville Ballygroman
    Kilumney
    IRISH Ovens
    County Cork
    Ireland
    Administrateur
    Sommerville Ballygroman
    Kilumney
    IRISH Ovens
    County Cork
    Ireland
    IrelandIrish66958110003
    PAGE, Robert Scott
    42 St Johns Road
    EH12 6PA Edinburgh
    Administrateur
    42 St Johns Road
    EH12 6PA Edinburgh
    British47726240001
    SNOWIE, Alistair
    The Loaning Gogar Loan
    Blairlogie
    FK9 5QE Stirling
    Administrateur
    The Loaning Gogar Loan
    Blairlogie
    FK9 5QE Stirling
    British62542180002
    SNOWIE, Euan Fenwick
    Boquhan House
    Kippen
    Stirlingshire
    Administrateur
    Boquhan House
    Kippen
    Stirlingshire
    ScotlandScottish152234940002
    SNOWIE, Gordon Somerville
    Inverdunning House
    Dunning
    PH2 0QG Perthshire
    Administrateur
    Inverdunning House
    Dunning
    PH2 0QG Perthshire
    ScotlandBritish33931250003
    SNOWIE, Malcolm Mcdonald
    West Gogar
    Blairlogie
    FK9 5QB Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    West Gogar
    Blairlogie
    FK9 5QB Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritish1380960001

    SURFACE CONTROL (GLASGOW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 15 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    The obligations contained in the minute agreement
    Brèves mentions
    The farm of haugh, blackgrange, cambus, extending 46.3 hectares being the whole subjects clk 5583.
    Personnes ayant droit
    • Mage Farming and Consultancy Limited
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 15 sept. 2005
    Livré le 24 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Haugh of blackrange, cambus, clackmannanshire.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 24 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 09 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 09 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land and buildings known as 140 moss lane, macclesfield CH2275423 CH145909 CH468788.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 06 juil. 2004
    Livré le 15 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 3, gelders hall road, shepshed, leicestershire.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 15 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 15 avr. 2002
    Livré le 22 avr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects situated on the north east side of south bridge street, grangemouth.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 22 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 17 juil. 2000
    Livré le 21 juil. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1 to 5 abbotsinch road, grangemouth and 13 to 17 abbotsinch road, grangemouth.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 21 juil. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 30 juin 1998
    Livré le 21 juil. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Farm of haugh of blackrange,by cambus.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 21 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 30 juin 1998
    Livré le 13 juil. 1998
    En cours
    Montant garanti
    £175,000 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    Haugh of blackgrange,by cambus,clackmannanshire.
    Personnes ayant droit
    • William Oswald
    Transactions
    • 13 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 03 mars 1998
    Livré le 16 mars 1998
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Midtown farm,cambus,by alloa.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 16 mars 1998Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 14 août 1997
    Livré le 28 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 28 août 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 sept. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    SURFACE CONTROL (GLASGOW) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 août 2016Conclusion of winding up
    30 nov. 2016Due to be dissolved on
    18 févr. 2011Commencement of winding up
    18 févr. 2011Petition date
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Eileen Blackburn
    56 Palmerston Place
    EH12 5AY Edinburgh
    practitioner
    56 Palmerston Place
    EH12 5AY Edinburgh
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0