PATISSERIE UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPATISSERIE UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC154253
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PATISSERIE UK LIMITED ?

    • (1581) /

    Où se situe PATISSERIE UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Campbell Dallas
    7 Glasgow Road
    PA1 3QS Paisley
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PATISSERIE UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LA MAISON DU PATISSIER LIMITED29 nov. 200129 nov. 2001
    SUNGEM LIMITED14 nov. 199414 nov. 1994

    Quels sont les derniers comptes de PATISSERIE UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour PATISSERIE UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Avis de réunion finale des créanciers

    2 pages4.17(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    9 pages2.20B(Scot)

    Avis de passage de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    9 pages2.25B(Scot)

    Divers

    Duplicate termintaion 11/09/09 for raymond miquel
    1 pagesMISC

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    10 pages2.20B(Scot)

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages2.18B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.14B(Scot)/2.13B(Scot)

    23 pages2.15B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    27 pages2.16B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    11 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    13 pages155(6)a

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de PATISSERIE UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SIMSON, David John
    Whispers
    2a Pathhead Road
    G76 9AH Carmunnock
    Secrétaire
    Whispers
    2a Pathhead Road
    G76 9AH Carmunnock
    British35825130006
    HOOD, Robert James Reid
    Morgan Way
    Armadale
    EH48 2JB Bathgate
    31
    West Lothian
    Administrateur
    Morgan Way
    Armadale
    EH48 2JB Bathgate
    31
    West Lothian
    British133955990001
    MCMILLAN, Ian William
    24 Station Road
    Bearsden
    G61 4AL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    24 Station Road
    Bearsden
    G61 4AL Glasgow
    Lanarkshire
    British46604010002
    MILLAR, Nadia
    Inglefield
    Mosswell Road, Milngavie
    G62 8HB Glasgow
    Administrateur
    Inglefield
    Mosswell Road, Milngavie
    G62 8HB Glasgow
    United KingdomBritish92477590001
    MIQUEL, Clive John
    7 Lochend Crescent
    Bearsden
    G61 1EA Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Lochend Crescent
    Bearsden
    G61 1EA Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish94981710001
    SIMSON, David John
    Whispers
    2a Pathhead Road
    G76 9AH Carmunnock
    Administrateur
    Whispers
    2a Pathhead Road
    G76 9AH Carmunnock
    ScotlandBritish35825130006
    COYNE, Denis, Cllr
    24 Harviestoun Road
    FK14 7HG Dollar
    Clackmannanshire
    Secrétaire
    24 Harviestoun Road
    FK14 7HG Dollar
    Clackmannanshire
    British81491860001
    DOYLE, Evelyn
    Edmonston Cottage
    Old Dalkeith Road
    Edinburgh
    Secrétaire
    Edmonston Cottage
    Old Dalkeith Road
    Edinburgh
    British41183880002
    LONIE, Andrew
    75 Dudley Avenue
    EH6 4PL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    75 Dudley Avenue
    EH6 4PL Edinburgh
    Midlothian
    British67004220001
    MCKEE, Martin Jack
    24 Worsley Crescent
    Newton Mearns
    G77 6DW Glasgow
    Secrétaire
    24 Worsley Crescent
    Newton Mearns
    G77 6DW Glasgow
    British41647290001
    MCLACHLAN, John Fraser
    East Wing, Ryland Lodge
    Perth Road
    FK15 0HY Dunblane
    Perthshire
    Secrétaire
    East Wing, Ryland Lodge
    Perth Road
    FK15 0HY Dunblane
    Perthshire
    British106369050001
    STEVEN, Ian William
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    Secrétaire
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    British654410001
    LYCIDAS SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    900003290001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BEATTIE, David
    Craigsheen House
    23 Craigsheen Avenue
    G76 9AG Carmunnock
    Glasgow
    Administrateur
    Craigsheen House
    23 Craigsheen Avenue
    G76 9AG Carmunnock
    Glasgow
    ScotlandBritish237590004
    DOYLE, Evelyn
    545 Old Dalkeith Road
    EH16 4SR Edinburgh
    Administrateur
    545 Old Dalkeith Road
    EH16 4SR Edinburgh
    British60010710001
    INGLIS, Alan James
    55 Main Road
    Elderslie
    PA15 9BA Johnstone
    Renfrewshire
    Administrateur
    55 Main Road
    Elderslie
    PA15 9BA Johnstone
    Renfrewshire
    ScotlandBritish109847760001
    KNOX, Keith Carmichael
    46 Wishart Ave
    EH19 3QF Bonnyrigg
    Midlothian
    Administrateur
    46 Wishart Ave
    EH19 3QF Bonnyrigg
    Midlothian
    British60189040001
    KNOX, Michael
    Edmonston Cottage
    Old Dalkeith Road
    Edinburgh
    Administrateur
    Edmonston Cottage
    Old Dalkeith Road
    Edinburgh
    British74814540002
    MCCORMICK, John Robert
    17 Wellknowe Place
    Thorntonhall
    G74 5QA Glasgow
    Administrateur
    17 Wellknowe Place
    Thorntonhall
    G74 5QA Glasgow
    ScotlandBritish82210090001
    MCKEE, Martin Jack
    24 Worsley Crescent
    Newton Mearns
    G77 6DW Glasgow
    Administrateur
    24 Worsley Crescent
    Newton Mearns
    G77 6DW Glasgow
    ScotlandBritish41647290001
    MCLACHLAN, John Fraser
    East Wing, Ryland Lodge
    Perth Road
    FK15 0HY Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    East Wing, Ryland Lodge
    Perth Road
    FK15 0HY Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish106369050001
    MIQUEL, Raymond Clive
    Whitedene
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Tayside
    Administrateur
    Whitedene
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Tayside
    British32443200001
    MYATT, Edward Bamford
    47 Stephens Close
    Mortimor
    RG7 3TY Reading
    Administrateur
    47 Stephens Close
    Mortimor
    RG7 3TY Reading
    British41183830002
    ROBINSON, Stuart John
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    Administrateur
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    British63448390001
    RODEN, John Robert
    2 Whitelees Grove
    ML11 7RG Lanark
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Whitelees Grove
    ML11 7RG Lanark
    Lanarkshire
    ScotlandBritish111099690002
    STEVEN, Ian William
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    Administrateur
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    United KingdomBritish654410001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    PATISSERIE UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 03 déc. 2007
    Livré le 21 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 22 mars 2006
    Livré le 29 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 9 march 2006
    Brèves mentions
    The subjects and others extending to 0.9 acres at firth road, houston industrial estate, livingston (title number wln 35624).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 09 nov. 1999
    Livré le 18 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 nov. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 06 août 1996
    Livré le 13 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 13 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 15 mars 1995
    Livré le 17 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    PATISSERIE UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 mars 2010Administration ended
    06 mars 2009Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Forsyth
    Sherwood House
    7 Glasgow Road
    Paisley
    practitioner
    Sherwood House
    7 Glasgow Road
    Paisley
    David K Hunter
    Sherwood House
    7 Glasgow Road
    PA1 3QS Paisley
    practitioner
    Sherwood House
    7 Glasgow Road
    PA1 3QS Paisley
    2
    DateType
    02 févr. 2012Dissolved on
    05 mars 2010Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David K Hunter
    Sherwood House
    7 Glasgow Road
    PA1 3QS Paisley
    practitioner
    Sherwood House
    7 Glasgow Road
    PA1 3QS Paisley
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0